MARSHALLS 106 LIMITED

MARSHALLS 106 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSHALLS 106 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01496819
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARSHALLS 106 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova MARSHALLS 106 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower 42 Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARSHALLS 106 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    M.W. MARSHALL (U.K.) LIMITED29 ott 199329 ott 1993
    MARSHALLS 106 LIMITED28 gen 198828 gen 1988
    CLOAK LANE (INTERNATIONAL) LIMITED28 mar 198428 mar 1984
    CHARLES FULTON (INTERNATIONAL) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    CHARLES FULTON (COMMODITIES) LIMITED15 mag 198015 mag 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSHALLS 106 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSHALLS 106 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 mag 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2011

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 07 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 feb 2011

    Stato del capitale al 08 feb 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 20 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Robert Stevens come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barry Ward come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Evans come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robin James Stewart come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Richard Mainwaring il 29 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Remove s/cap clause 18/06/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 07 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Barry Charles Bernard Ward il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Brian Stevens il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Richard Mainwaring il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Keith Evans il 06 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Nicola Challen il 06 gen 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MARSHALLS 106 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Other119903660002
    MAINWARING, Paul Richard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritishFinance Director116302540002
    STEWART, Robin James
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritishTax Accountant161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Segretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Segretario
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Segretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Segretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Segretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    RAVER, Harold Mark
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    Segretario
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    British1493340004
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Segretario
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    BAILEY, Mark Adrian Stephen
    57 Grand Parade
    SS9 1DT Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    57 Grand Parade
    SS9 1DT Leigh On Sea
    Essex
    BritishAccountant50999360002
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    BritishChartered Accountant2039000001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Amministratore
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritishChartered Accountant35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Amministratore
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    BritishGroup Finance Director54679190001
    EVANS, Andrew Keith
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritishAccountant124021620001
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Amministratore
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    AustralianAccountant113674080001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Amministratore
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritishFinance Director13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Amministratore
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    AustralianCompany Director42704380002
    KELSON, Christopher John Kerry
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    Amministratore
    10 Charles Ii Place
    77 Kings Road Chelsea
    SW3 4NG London
    BritishMoney Broker2039010003
    PLASCO, Joel Darren
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    Amministratore
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    BritishCompany Director78522900003
    PLUNKETT, Stephen David
    Hillcrest Childerditch Lane
    Little Warley
    CM13 3EQ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Hillcrest Childerditch Lane
    Little Warley
    CM13 3EQ Brentwood
    Essex
    BritishMoneybroker141627450001
    POTTER, Michael John William
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Blackhall Spinney
    Blackhall Lane
    TN15 0HP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant21712170002
    RILEY, Jacqueline Anne Louise
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    Amministratore
    13 Herald's Place
    Renfrew Road
    SE11 4NP London
    EnglandBritishGroup Accountant38508990001
    STEVENS, Robert Brian
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritishChartered Accountant129608370001
    TAYLOR, Kim Michael
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    Amministratore
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    BritishDirector34697370003
    WARD, Barry Charles Bernard
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritishAccountant126732970001

    MARSHALLS 106 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mag 1999
    Consegnato il 16 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee each and every liability arising under the finance documents which the company may have had at the time the debenture was entered into or thereafter have to the security trustee or any of the beneficiaries and pay to the security trustee every sum now or thereafter owing due or incurred by the company to the security trustee or any of the beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 19 giu 1981
    Consegnato il 01 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & debts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery (see doc M10).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limitedas Agent
    Transazioni
    • 01 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 20 ago 1980
    Consegnato il 03 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h properties present and future with fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Goodwill and uncalled capital and present and future. Undertaking and all other property and assets present and future including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charge. (Please see doc M9).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1980Registrazione di un'ipoteca

    MARSHALLS 106 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mag 2011Inizio della liquidazione
    14 set 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0