KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED

KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01499856
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Vulcan Road
    WV14 7HT Bilston
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 dic 2015

    Stato del capitale al 01 dic 2015

    • Capitale: GBP 58
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2014

    Stato del capitale al 21 nov 2014

    • Capitale: GBP 58
    SH01

    Cessazione della carica di Douglas John Allen come amministratore in data 10 nov 2014

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Howard Dell il 13 ott 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Howard Dell il 13 ott 2014

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2013

    Stato del capitale al 27 nov 2013

    • Capitale: GBP 58
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Martin Killeen il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Rubber Astic Ltd, Vulcan Road, Bilston West Midlands WV14 7HT* in data 14 gen 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    11 pagineMG01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Martin Killeen il 20 nov 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2008

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DELL, Michael Howard
    Cottage Mews, Chester Road
    Aldridge
    WS9 0NZ Walsall
    1
    England
    Segretario
    Cottage Mews, Chester Road
    Aldridge
    WS9 0NZ Walsall
    1
    England
    BritishDirector50147390001
    DELL, Michael Howard
    Cottage Mews, Chester Road
    Aldridge
    WS9 0NZ Walsall
    1
    England
    Amministratore
    Cottage Mews, Chester Road
    Aldridge
    WS9 0NZ Walsall
    1
    England
    EnglandBritishDirector50147390004
    KILLEEN, Paul Martin
    Vulcan Road
    WV14 7HT Bilston
    20
    West Midlands
    Amministratore
    Vulcan Road
    WV14 7HT Bilston
    20
    West Midlands
    EnglandBritishSales Director74128930002
    HUBBARD, Joseph William Henry
    4 Wednesbury Oak Road
    DY4 0BS Tipton
    West Midlands
    Segretario
    4 Wednesbury Oak Road
    DY4 0BS Tipton
    West Midlands
    British15847420001
    KEELING, Heather Mary
    5 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JE Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    5 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JE Wolverhampton
    West Midlands
    British20467770001
    ROUND, Anthony John
    Brandelhowe
    Springhill Lane
    WV4 4TW Lower Penn
    West Midlands
    Segretario
    Brandelhowe
    Springhill Lane
    WV4 4TW Lower Penn
    West Midlands
    British19895580001
    SANDERS, Michael John Stuart
    17 Sylvan Close
    TF10 9EQ Lilleshall
    Salop
    Segretario
    17 Sylvan Close
    TF10 9EQ Lilleshall
    Salop
    BritishAccountant75975850001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    ALLEN, Douglas John
    Virginia Cottage Shawmans Lane
    Haughton
    ST18 9JW Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Virginia Cottage Shawmans Lane
    Haughton
    ST18 9JW Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector23854270001
    BALIANA, Polla Singh
    55 Island Road
    Handsworth
    B21 8NS Birmingham
    Amministratore
    55 Island Road
    Handsworth
    B21 8NS Birmingham
    BritishWorks Director37965720001
    BREAKWELL, Richard Paul
    49 Prouds Lane
    WV14 6QA Bilston
    West Midlands
    England
    Amministratore
    49 Prouds Lane
    WV14 6QA Bilston
    West Midlands
    England
    BritishSales Director24381530002
    HANCOX, Gary
    17 Myvod Road
    WS10 9BT Wednesbury
    West Midlands
    Amministratore
    17 Myvod Road
    WS10 9BT Wednesbury
    West Midlands
    BritishSales Director14647700001
    HUBBARD, Joseph William Henry
    4 Wednesbury Oak Road
    DY4 0BS Tipton
    West Midlands
    Amministratore
    4 Wednesbury Oak Road
    DY4 0BS Tipton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary15847420001
    KEELING, Heather Mary
    New House Farm Nib Green
    Arley
    DY12 3LY Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    New House Farm Nib Green
    Arley
    DY12 3LY Bewdley
    Worcestershire
    BritishCo-Secretary/Finanical Directo20467770002
    KEELING, Kenneth Arthur
    Upper Thorpe
    Edge Hill
    DY7 6DP Kinver
    West Midlands
    Amministratore
    Upper Thorpe
    Edge Hill
    DY7 6DP Kinver
    West Midlands
    BritishChairman3598600001
    KEELING, Michael
    Eastwood House 5 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JE Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Eastwood House 5 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JE Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector - Managing Director14647710001
    MACHIN, Norman Graham
    1 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JF Wolverhampton
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Birches Road
    Codsall
    WV8 2JF Wolverhampton
    Staffordshire
    BritishWorks Director43624950001
    RHODES, Alan
    21 Jockey Lane
    WS10 9BB Wednesbury
    West Midlands
    Amministratore
    21 Jockey Lane
    WS10 9BB Wednesbury
    West Midlands
    United KingdomBritishSales Director14647720001
    ROUND, Anthony John
    Brandelhowe
    Springhill Lane
    WV4 4TW Lower Penn
    West Midlands
    Amministratore
    Brandelhowe
    Springhill Lane
    WV4 4TW Lower Penn
    West Midlands
    EnglandBritishDirector19895580001
    RYDER, Peter David
    Wilow Croft 42 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Wilow Croft 42 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    BritishDirector3179100006
    SANDERS, Michael John Stuart
    17 Sylvan Close
    TF10 9EQ Lilleshall
    Salop
    Amministratore
    17 Sylvan Close
    TF10 9EQ Lilleshall
    Salop
    BritishAccountant75975850001
    WALKER, Robert William
    Upper Monkhall
    Monkhopton
    WV16 6XF Bridgnorth
    Shropshire
    Amministratore
    Upper Monkhall
    Monkhopton
    WV16 6XF Bridgnorth
    Shropshire
    BritishCompany Director9196760002

    KEELING RUBBER & PLASTICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Full form debenture
    Creato il 02 giu 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2003
    Consegnato il 04 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 27 giu 2003
    Consegnato il 03 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all book debts owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Robert William Walker and Joseph William Henry Hubbard
    Transazioni
    • 03 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2003
    Consegnato il 03 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Plant & equipment referred to in the schedule to the deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert William Walker and Joseph William Henry Hubbard
    Transazioni
    • 03 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 09 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit C5 hilton trading estate lanesfield wolverhampton west midlands t/no.WM636214. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 24 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ott 1987
    Consegnato il 23 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 10 spring road industrial estate spring rd, ettingshall wolverhampton, W. midlands (title no wm 171780) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0