HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED

HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01501883
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    200 Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VIDEO CONTROLS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    BALRETONE LIMITED13 giu 198013 giu 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Jane Earle il 01 dic 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 gen 2020

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB United Kingdom a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd

    1 pagineAD02

    Nomina di Elizabeth Jane Earle come amministratore in data 15 mar 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB United Kingdom a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd in data 13 mar 2019

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Ashish Kumar Saraf come amministratore in data 26 ott 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Michele Elaine Hudson come amministratore in data 26 ott 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Allan Richards come amministratore in data 26 ott 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 21 Holborn Viaduct London EC1A 2DY United Kingdom a Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate Runcorn Cheshire WA7 3DL a Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB in data 20 nov 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EARLE, Elizabeth Jane
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    Amministratore
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Controller256881430001
    HUDSON, Michele Elaine
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    Amministratore
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    ScotlandBritishDirector251257190001
    RICHARDS, Allan
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    Amministratore
    Berkshire Place
    RG41 5RD Winnersh Triangle
    200
    Berkshire
    EnglandBritishDirector55171600002
    BURTON, Philip Michael
    41 Howey Lane
    Frodsham
    WA6 6DD Warrington
    Cheshire
    Segretario
    41 Howey Lane
    Frodsham
    WA6 6DD Warrington
    Cheshire
    British24331020001
    MCKEE, Martin Jack
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    Segretario
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    BritishAccountant41647290001
    POTTER, Keith Douglas
    Endleigh Croeshowell Lane Burton
    Rossett
    LL12 0LB Wrexham
    Clwyd
    Segretario
    Endleigh Croeshowell Lane Burton
    Rossett
    LL12 0LB Wrexham
    Clwyd
    BritishAccountant57513980001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SISEC LIMITED
    Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    21
    United Kingdom
    Segretario
    Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    21
    United Kingdom
    133440030001
    BATCHELOR, Anthony Charles
    25 Mill Lane
    GU46 7TE Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    25 Mill Lane
    GU46 7TE Yateley
    Hampshire
    United KingdomBritishOperations Director68018480002
    BRENNAN, Paul
    40 Hillside Drive
    Wayland Ma 01778
    Usa
    Amministratore
    40 Hillside Drive
    Wayland Ma 01778
    Usa
    AmericanVice President Finance53710440001
    BROOK, Michael George
    Latchetts 6 Gorse Bank Road
    Halebarns
    WA15 0AL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Latchetts 6 Gorse Bank Road
    Halebarns
    WA15 0AL Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector25222620002
    BURTON, Philip Michael
    Poolhead
    Oulton Mill Lane, Cotebrook
    CW6 9DX Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Poolhead
    Oulton Mill Lane, Cotebrook
    CW6 9DX Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director24331020002
    CARPENTER, Howard Frederick
    Skimped Hill Lane
    RG12 1EB Bracknell
    Honeywell House
    Berks
    United Kingdom
    Amministratore
    Skimped Hill Lane
    RG12 1EB Bracknell
    Honeywell House
    Berks
    United Kingdom
    United KingdomBritishProgramme Manager155687070001
    FERNANDEZ, Mervyn Cajetan
    1 Henwick Close
    Ashmore Green Road
    RG18 9EW Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Henwick Close
    Ashmore Green Road
    RG18 9EW Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant242329540001
    FRASER, Grant William
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    Amministratore
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    ScotlandBritishCompany Director127713450002
    HOCKHAM, Jeremey Francis
    15 Greatford Gardens
    PE9 4PX Greatford
    Lincolnshire
    Amministratore
    15 Greatford Gardens
    PE9 4PX Greatford
    Lincolnshire
    BritishManaging Director123513870001
    HOUGHTON, Michael
    19 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    19 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    BritishSales Director43987610001
    KRAMVIS, Andreas
    66 Randolph Drive
    Dix Hills
    FOREIGN Ny 11746 Usa
    Amministratore
    66 Randolph Drive
    Dix Hills
    FOREIGN Ny 11746 Usa
    Us CitizenDirector61161980002
    LLOYD, Andrew Nigel
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    Amministratore
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director76992750001
    MCBETH, Colin
    21 Cowal View
    PA19 1EX Gourock
    Renfrewshire
    Amministratore
    21 Cowal View
    PA19 1EX Gourock
    Renfrewshire
    BritishHr Director76066620001
    MCCORMACK, Stuart Robert
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    Amministratore
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant206977170001
    MCKEE, Martin Jack
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    Amministratore
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    ScotlandBritishAccountant41647290001
    NARGOLWALA, Vineet Arun
    Little Haining
    Brokenhurst Road South
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Little Haining
    Brokenhurst Road South
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    United States CitizGeneral Manager127166720002
    NEILSON, Simon John
    2 Southwold
    RG12 8XY Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    2 Southwold
    RG12 8XY Bracknell
    Berkshire
    BritishFinance Manager Emea114949790001
    PARKINS, Keith
    The Old Granary
    10 Telegraph Road
    CH60 2SA Heswall
    Wirral
    Amministratore
    The Old Granary
    10 Telegraph Road
    CH60 2SA Heswall
    Wirral
    EnglandBritishElectronics Engineer94084000001
    PROSSER, John Melville
    Stonewold House
    Main Street, Tadmarton
    OX15 5SG Banbury
    Amministratore
    Stonewold House
    Main Street, Tadmarton
    OX15 5SG Banbury
    BritishDistribution Sales Director93646050001
    PROTHEROE, David Jason Lloyd
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    Amministratore
    4 Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director31826530001
    RICHARDS, Allan
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    Amministratore
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    EnglandBritishSolicitor55171600002
    SAMUELS, Alan
    Peninsula
    Heath Ride
    RG40 3QJ Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Peninsula
    Heath Ride
    RG40 3QJ Finchampstead
    Berkshire
    United States CitizenManaging Director Emea114991470001
    SARAF, Ashish Kumar
    Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Aston Fields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    4
    Cheshire
    England
    IndiaIndianDirector225393150001
    VAN DER MEY, Robert
    The Old Rectory Rectory Road
    Campton
    SG17 5PF Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Old Rectory Rectory Road
    Campton
    SG17 5PF Shefford
    Bedfordshire
    DutchExport Director30877150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Astonfields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    3-4 & 8-9
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Astonfields Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DL Runcorn
    3-4 & 8-9
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02558116
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 15 mar 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Scottish provident life policy numbered 3622608C.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 mar 2001
    Consegnato il 04 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of life policy
    Creato il 13 mar 1998
    Consegnato il 18 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy if life assurance numbered 3622608C dated 12 december 1997 on the life of philip michael burton for the sum of £500,000.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1997
    Consegnato il 17 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 10 apr 1995
    Consegnato il 14 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement leasing agreement or otherwise in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company.all other book and other debts and claims both present and future due or owing to or purchased or otherwise acquired by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 mag 1988
    Consegnato il 06 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0