HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01501883 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 200 Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle Berkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
VIDEO CONTROLS LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
BALRETONE LIMITED | 13 giu 1980 | 13 giu 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Jane Earle il 01 dic 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 27 gen 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB United Kingdom a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Jane Earle come amministratore in data 15 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB United Kingdom a 200 Berkshire Place Winnersh Triangle Berkshire RG41 5rd in data 13 mar 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashish Kumar Saraf come amministratore in data 26 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Michele Elaine Hudson come amministratore in data 26 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Allan Richards come amministratore in data 26 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 21 Holborn Viaduct London EC1A 2DY United Kingdom a Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate Runcorn Cheshire WA7 3DL a Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell Berks RG12 1EB in data 20 nov 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARLE, Elizabeth Jane | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | England | British | Financial Controller | 256881430001 | ||||
HUDSON, Michele Elaine | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | Scotland | British | Director | 251257190001 | ||||
RICHARDS, Allan | Amministratore | Berkshire Place RG41 5RD Winnersh Triangle 200 Berkshire | England | British | Director | 55171600002 | ||||
BURTON, Philip Michael | Segretario | 41 Howey Lane Frodsham WA6 6DD Warrington Cheshire | British | 24331020001 | ||||||
MCKEE, Martin Jack | Segretario | 24 Worsley Crescent Newton Mearns G77 6DW Glasgow | British | Accountant | 41647290001 | |||||
POTTER, Keith Douglas | Segretario | Endleigh Croeshowell Lane Burton Rossett LL12 0LB Wrexham Clwyd | British | Accountant | 57513980001 | |||||
EPS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
SISEC LIMITED | Segretario | Holborn Viaduct EC1A 2DY London 21 United Kingdom | 133440030001 | |||||||
BATCHELOR, Anthony Charles | Amministratore | 25 Mill Lane GU46 7TE Yateley Hampshire | United Kingdom | British | Operations Director | 68018480002 | ||||
BRENNAN, Paul | Amministratore | 40 Hillside Drive Wayland Ma 01778 Usa | American | Vice President Finance | 53710440001 | |||||
BROOK, Michael George | Amministratore | Latchetts 6 Gorse Bank Road Halebarns WA15 0AL Altrincham Cheshire | England | British | Director | 25222620002 | ||||
BURTON, Philip Michael | Amministratore | Poolhead Oulton Mill Lane, Cotebrook CW6 9DX Tarporley Cheshire | England | British | Managing Director | 24331020002 | ||||
CARPENTER, Howard Frederick | Amministratore | Skimped Hill Lane RG12 1EB Bracknell Honeywell House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | Programme Manager | 155687070001 | ||||
FERNANDEZ, Mervyn Cajetan | Amministratore | 1 Henwick Close Ashmore Green Road RG18 9EW Thatcham Berkshire | England | British | Accountant | 242329540001 | ||||
FRASER, Grant William | Amministratore | 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn Cheshire | Scotland | British | Company Director | 127713450002 | ||||
HOCKHAM, Jeremey Francis | Amministratore | 15 Greatford Gardens PE9 4PX Greatford Lincolnshire | British | Managing Director | 123513870001 | |||||
HOUGHTON, Michael | Amministratore | 19 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | Sales Director | 43987610001 | |||||
KRAMVIS, Andreas | Amministratore | 66 Randolph Drive Dix Hills FOREIGN Ny 11746 Usa | Us Citizen | Director | 61161980002 | |||||
LLOYD, Andrew Nigel | Amministratore | 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 76992750001 | ||||
MCBETH, Colin | Amministratore | 21 Cowal View PA19 1EX Gourock Renfrewshire | British | Hr Director | 76066620001 | |||||
MCCORMACK, Stuart Robert | Amministratore | 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 206977170001 | ||||
MCKEE, Martin Jack | Amministratore | 24 Worsley Crescent Newton Mearns G77 6DW Glasgow | Scotland | British | Accountant | 41647290001 | ||||
NARGOLWALA, Vineet Arun | Amministratore | Little Haining Brokenhurst Road South SL5 9HB Ascot Berkshire | United States Citiz | General Manager | 127166720002 | |||||
NEILSON, Simon John | Amministratore | 2 Southwold RG12 8XY Bracknell Berkshire | British | Finance Manager Emea | 114949790001 | |||||
PARKINS, Keith | Amministratore | The Old Granary 10 Telegraph Road CH60 2SA Heswall Wirral | England | British | Electronics Engineer | 94084000001 | ||||
PROSSER, John Melville | Amministratore | Stonewold House Main Street, Tadmarton OX15 5SG Banbury | British | Distribution Sales Director | 93646050001 | |||||
PROTHEROE, David Jason Lloyd | Amministratore | 4 Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 31826530001 | ||||
RICHARDS, Allan | Amministratore | 12 Thistle Grove SW10 9RZ London | England | British | Solicitor | 55171600002 | ||||
SAMUELS, Alan | Amministratore | Peninsula Heath Ride RG40 3QJ Finchampstead Berkshire | United States Citizen | Managing Director Emea | 114991470001 | |||||
SARAF, Ashish Kumar | Amministratore | Aston Fields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn 4 Cheshire England | India | Indian | Director | 225393150001 | ||||
VAN DER MEY, Robert | Amministratore | The Old Rectory Rectory Road Campton SG17 5PF Shefford Bedfordshire | Dutch | Export Director | 30877150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video Controls Limited | 06 apr 2016 | Astonfields Road Whitehouse Industrial Estate WA7 3DL Runcorn 3-4 & 8-9 Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
HONEYWELL VIDEO SYSTEMS UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creato il 15 mar 2001 Consegnato il 04 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Scottish provident life policy numbered 3622608C. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 mar 2001 Consegnato il 04 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of life policy | Creato il 13 mar 1998 Consegnato il 18 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The policy if life assurance numbered 3622608C dated 12 december 1997 on the life of philip michael burton for the sum of £500,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 dic 1997 Consegnato il 17 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge over book debts | Creato il 10 apr 1995 Consegnato il 14 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement leasing agreement or otherwise in any manner whatsoever | |
Brevi particolari The ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company.all other book and other debts and claims both present and future due or owing to or purchased or otherwise acquired by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 27 mag 1988 Consegnato il 06 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0