HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED

HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01503246
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    • Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni

    Dove si trova HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kingsley Hall 20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Dan Squiller come amministratore in data 15 ott 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 015032460008 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    legacy

    19 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione della carica di Michael Vivaldi come amministratore in data 31 ago 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Redwither Works Redwither Road Wrexham Industrial Estate Wrexham Clwyd LL13 9rd a Kingsley Hall 20 Bailey Lane Manchester Airport Manchester M90 4AN in data 01 feb 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di H.T.C. Management Services Ltd come persona con controllo significativo il 01 nov 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Mike Vivaldi come persona con controllo significativo il 01 nov 2017

    1 paginePSC07

    Cessazione di Richard Coffey come persona con controllo significativo il 01 nov 2017

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Allen Yurko come amministratore in data 23 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew John Fisher come amministratore in data 31 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Timothy Garnet Bowen come amministratore in data 02 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Matthew James Hanson come amministratore in data 25 set 2017

    2 pagineAP01

    legacy

    18 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Allen Yurko come amministratore in data 31 mag 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew John Fisher come amministratore in data 31 mag 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOWEN, Timothy Garnet
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    Amministratore
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    EnglandBritish240129800001
    HANSON, Matthew James
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    Amministratore
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    EnglandBritish240127140001
    CHRISTOPHER, Richard Talbot
    Langhorne
    Chester Road, Kelsall
    CW6 0SB Tarporley
    Cheshire
    Segretario
    Langhorne
    Chester Road, Kelsall
    CW6 0SB Tarporley
    Cheshire
    British76447900001
    JOHNSON, Sandra
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    Segretario
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    British23142940002
    CHRISTOPHER, Richard Talbot
    Langhorne
    Chester Road, Kelsall
    CW6 0SB Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Langhorne
    Chester Road, Kelsall
    CW6 0SB Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish76447900001
    COFFEY, Richard
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Amministratore
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    United KingdomBritish91825930001
    FISHER, Andrew John
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Amministratore
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    EnglandBritish79624010001
    JOHNSON, Sandra
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    Amministratore
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    British23142940002
    JOHNSON, Warren George
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    Amministratore
    Fieldings
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    United KingdomBritish168111340001
    LACEY, Mark Edward
    Dog Lane
    Kelsall
    CW6 0RP Tarporley
    Rose Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dog Lane
    Kelsall
    CW6 0RP Tarporley
    Rose Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109295340004
    MANNERS, Cameron
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Amministratore
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    UsaCanadian190551320001
    SQUILLER, Dan
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    Amministratore
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    United StatesAmerican231561740001
    VIVALDI, Michael
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    Amministratore
    20 Bailey Lane
    Manchester Airport
    M90 4AN Manchester
    Kingsley Hall
    England
    CanadaCanadian201704380001
    YURKO, Allen
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Amministratore
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    UsaBritish232781410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    H.T.C. Management Services Ltd
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Wales
    01 nov 2017
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Wales
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione04221732
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Mr Mike Vivaldi
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    06 apr 2016
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Nazionalità: Canadian
    Paese di residenza: Canada
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Richard Coffey
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    06 apr 2016
    Redwither Road
    Wrexham Industrial Estate
    LL13 9RD Wrexham
    Redwither Works
    Clwyd
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    HYDROSTATIC TESTING CONSULTANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 set 2015
    Consegnato il 30 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wf Fund Iv Limited Partnership
    Transazioni
    • 30 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 nov 2010
    Consegnato il 12 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 mag 2010
    Consegnato il 10 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 set 2001
    Consegnato il 17 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Warren George Johnson and Sandra Johnson
    Transazioni
    • 17 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 ago 1999
    Consegnato il 27 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 mag 1991
    Consegnato il 13 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 427 ash road wrexham industrial estate wrexham clwyd. Fixed charge over all movable plant and machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 giu 1984
    Consegnato il 30 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 lug 1981
    Consegnato il 03 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0