LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED

LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01507411
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di articoli per la casa (esclusi strumenti musicali) n.c.a. (46499) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LI-LO LIMITED21 ott 198221 ott 1982
    R. MASKELL (GARDEN FURNITURE) LIMITED11 lug 198011 lug 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    5 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ago 2020

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ago 2019

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ago 2018

    23 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Watergate Broxhill Road Havering Atte Bower Romford Essex RM4 1QH a The Old Exchange 234 Southchurch Road Southend on Sea Essex SS1 2EG in data 11 set 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    14 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 25 ago 2017

    LRESEX

    Nomina di Mr Nicholas Richard Maskell come segretario in data 05 giu 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tulin Mustafa come segretario in data 05 giu 2017

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    28 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 dic 2015 al 28 dic 2015

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2015 al 29 dic 2015

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sterling House Langston Road Loughton Essex IG10 3TS a Watergate Broxhill Road Havering Atte Bower Romford Essex RM4 1QH in data 26 ago 2016

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ott 2015

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 dic 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2014

    Stato del capitale al 08 set 2014

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 set 2013

    Stato del capitale al 12 set 2013

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 015074110014

    14 pagineMR01

    Cessazione della carica di Roger Humphries come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASKELL, Nicholas Richard
    Broxhill Road
    Havering-Atte-Bower
    RM4 1QH Romford
    Mylands Farm
    England
    Segretario
    Broxhill Road
    Havering-Atte-Bower
    RM4 1QH Romford
    Mylands Farm
    England
    232868990001
    GILBERT, Lawrence Jefferson
    4 May Gardens
    Elstree
    WD6 3RZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 May Gardens
    Elstree
    WD6 3RZ Borehamwood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSales Director16514470002
    HARDEN, Trevor Thomas
    35 Meadow Way
    Farnborough Park
    BR6 8LN Orpington
    Kent
    Amministratore
    35 Meadow Way
    Farnborough Park
    BR6 8LN Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant55928630001
    MASKELL, Nicholas Richard
    Sawkins Farm
    Mount End Road Theydon Mount
    CM16 7PS Epping
    Essex
    Amministratore
    Sawkins Farm
    Mount End Road Theydon Mount
    CM16 7PS Epping
    Essex
    United KingdomBritishBusinessman90961010001
    COOPER, Roy
    16 Maryon Mews
    Hampstead
    NW3 2PU London
    Segretario
    16 Maryon Mews
    Hampstead
    NW3 2PU London
    British7069260001
    MUSTAFA, Tulin
    11 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    11 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    British13332540003
    BELL, Graham Andrew
    55 Cloverly Road
    CM5 9BX Ongar
    Essex
    Amministratore
    55 Cloverly Road
    CM5 9BX Ongar
    Essex
    United KingdomBritishDirector83606930003
    COHEN, Martin
    37 Springfield Court
    Forsythia Close
    IG1 2BN Ilford
    Essex
    Amministratore
    37 Springfield Court
    Forsythia Close
    IG1 2BN Ilford
    Essex
    BritishDirector107566020001
    COOPER, Roy
    16 Maryon Mews
    Hampstead
    NW3 2PU London
    Amministratore
    16 Maryon Mews
    Hampstead
    NW3 2PU London
    BritishFinancial Director7069260001
    HUMPHRIES, Roger John
    Halyards Court
    12 Western Road
    RM1 3GL Romford
    31
    Amministratore
    Halyards Court
    12 Western Road
    RM1 3GL Romford
    31
    United KingdomBritishDirector84162230002
    MARREN, David Martin
    15 Condor Grove
    Heath Hayes
    WS12 5YB Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    15 Condor Grove
    Heath Hayes
    WS12 5YB Cannock
    Staffordshire
    BritishDirector16822190001
    MASKELL, Richard Henry
    Mylands Farm Broxhill Road
    Havering Atte Bower
    RM4 1QJ Romford
    Essex
    Amministratore
    Mylands Farm Broxhill Road
    Havering Atte Bower
    RM4 1QJ Romford
    Essex
    EnglandBritishChairman16514460001
    SHURMER, Kevin James
    The Stables Church Road
    Kirkby Mallory
    LE9 7QE Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Stables Church Road
    Kirkby Mallory
    LE9 7QE Leicester
    Leicestershire
    BritishSales And Marketing44228960001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Richard Henry Maskell
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old Exchange
    Essex
    01 set 2016
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    The Old Exchange
    Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 11 lug 2013
    Consegnato il 23 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of London and the Middle East PLC
    Transazioni
    • 23 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal mortgage
    Creato il 10 lug 2012
    Consegnato il 26 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property known as plot 5, cupola way, scunthorpe, north lincolnshire see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of London and the Middle East PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 lug 2012
    Consegnato il 26 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all other monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments, equipment, current accounts, intellectual property rights, uncalled capital and all authorisations. By way of floating charge all present and future business, undertaking and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of London and the Middle East PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property being cupola scunthorpe north lincs.
    Persone aventi diritto
    • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H proprty being rima house barking essex.
    Persone aventi diritto
    • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being rima house ripple road barking essex t/no EGL207619, f/h property being cupola scunthorpe north lincs t/no HS211465.
    Persone aventi diritto
    • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 feb 1996
    Consegnato il 20 feb 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 05 feb 1996
    Consegnato il 16 feb 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a containerways, ripple road, barking, essex t/no. EGL207619 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 16 mar 1992
    Consegnato il 24 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to any clauses of the guaranteeand debenture or any agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Overseas Trust Bank Limited
    Transazioni
    • 24 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 dic 1991
    Consegnato il 05 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The estate and interest of the conpany in the l/h property k/a:olsen shed no.1, Millwall inner dock, lb of tower hamlets. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Italian International Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ago 1985
    Consegnato il 02 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and/or the associated companies
    Brevi particolari
    Stocks shares and securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Banco Exterior UK Sa
    Transazioni
    • 02 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 ago 1985
    Consegnato il 21 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the assets.
    Persone aventi diritto
    • Ucm International Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1985Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 28 dic 1984
    Consegnato il 04 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 19/9/84 as amended by a letter dated 28/9/84
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (see form 395 for full details) by way of a continuing security the estate and interest of the company in the l/h property known as olsen shed no. 1, millwall inner dock, london borough of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1985Registrazione di un'ipoteca (395)

    LI-LO LEISURE PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 ago 2017Inizio della liquidazione
    15 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Wayne Macpherson
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Praticante
    Begbies Traynor The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Louise Donna Baxter
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend On Sea

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0