E.C.T. CELLULAR LIMITED

E.C.T. CELLULAR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàE.C.T. CELLULAR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01509414
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXECUTIVE CAR TELEPHONES LIMITED06 dic 198406 dic 1984
    MARC ALBERT - EXECUTIVE CAR TELEPHONES LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    MATFIELD LIMITED28 lug 198028 lug 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 feb 2011

    Stato del capitale al 15 feb 2011

    • Capitale: GBP 62,500
    SH01

    Nomina di Joanne Sarah Finch come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Richard Wolfgang Henry Schäfer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Allen come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Nowak come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Martin John Purkess il 01 lug 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    33 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Conflict 18/12/2009
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Dettagli del direttore cambiati per Thomas Nowak il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Philip Quentin Allen il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Purkess il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di E.C.T. CELLULAR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    British1058000001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Segretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COX, Homersham Martin
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Littlewood Park View
    Buxted
    TN22 4LS Uckfield
    East Sussex
    British1058000001
    DIPRE, Paul Vincent
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Junta
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    British3747590001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish45868080001
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Amministratore
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    British83517310001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SAMUEL, James Charles Marshall
    1 Grove Place
    Tatsfield
    TN16 2BA Westerham
    Kent
    Amministratore
    1 Grove Place
    Tatsfield
    TN16 2BA Westerham
    Kent
    British24141650001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    British95223480001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish76074580001

    E.C.T. CELLULAR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 apr 1992
    Consegnato il 19 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details- doc M75. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 19 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1989
    Consegnato il 20 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handlesbanken
    Transazioni
    • 20 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 mar 1988
    Consegnato il 07 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies deposited with the bank to the credited of the account mod. 0182273 designated E.C.T. cellular PLC. (See doc. For full details.).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 gen 1988
    Consegnato il 08 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Markheath house 1238-1248 high rd whetstao london M20 together with all buildings and fixtures thereon goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 15 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares & other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 set 1986
    Consegnato il 01 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as units 1 and 2 findley industrial estate, 879 high road, north finfhley l/b of barnet title no. Ngl 456815. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 01 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Deed
    Creato il 17 lug 1985
    Consegnato il 18 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 17 july 1985.
    Brevi particolari
    The sum of £16,180 deposited with barclays bank PLC 1 pall mall east london SW1 in an account designated whittingham/ect re unit 1 finchley industrial centre.
    Persone aventi diritto
    • Whittingham London Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0