WILSON PECK PROPERTIES LIMITED

WILSON PECK PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILSON PECK PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01511332
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 dic 2015

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 set 2015

    Stato del capitale al 28 set 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Stuart Gyles il 23 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Howard Barraclough il 23 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 set 2014

    Stato del capitale al 17 set 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 04 gen 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2013

    Stato del capitale al 08 ott 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 13 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOX, Bernadette
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    Segretario
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    British126339720002
    BARRACLOUGH, John Howard
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    Amministratore
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    EnglandEnglish90172020002
    GRADEL, David
    13 High View Gardens
    Finchley
    N3 3EX London
    Amministratore
    13 High View Gardens
    Finchley
    N3 3EX London
    United KingdomBritish1590720001
    GYLES, Robert Stuart
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    Amministratore
    Britannia House
    960 High Road
    N12 9RY London
    United KingdomBritish104637790003
    FULLALOVE, Deanna
    18 Springfields
    Somerset Road New Barnet
    EN5 1SG Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    18 Springfields
    Somerset Road New Barnet
    EN5 1SG Barnet
    Hertfordshire
    British65539830003
    JACOBS, Laurence Anthony
    29 The Heights
    IG10 1RN Loughton
    Essex
    Segretario
    29 The Heights
    IG10 1RN Loughton
    Essex
    British67329390003
    RIDEHALGH, Frank
    38 Scarborough Road
    FY8 3ES St Annes On Sea
    Lancashire
    Segretario
    38 Scarborough Road
    FY8 3ES St Annes On Sea
    Lancashire
    British36400480001
    ROBINSON, Margaret
    8 Alpine Walk
    The Common
    HA7 3HU Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    8 Alpine Walk
    The Common
    HA7 3HU Stanmore
    Middlesex
    Other109710630001
    DEAKIN, Michael David
    33 Dalebrook Court
    Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PQ Sheffield
    Amministratore
    33 Dalebrook Court
    Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PQ Sheffield
    United KingdomBritish2991220001
    GRADEL, Jack
    18 Old Hall Road
    Broughton Park
    M7 0JH Manchester
    Amministratore
    18 Old Hall Road
    Broughton Park
    M7 0JH Manchester
    British2991230001
    JACOBS, Laurence Anthony
    29 The Heights
    IG10 1RN Loughton
    Essex
    Amministratore
    29 The Heights
    IG10 1RN Loughton
    Essex
    British67329390003
    MATHIAS, Thomas Reginald Richard
    Park Head Farm
    Pines Lane
    ST8 7SR Biddulph Park
    Staffordshire
    Amministratore
    Park Head Farm
    Pines Lane
    ST8 7SR Biddulph Park
    Staffordshire
    British3927120001
    ORMEROD, David Anthony
    3 Wheatfield Avenue
    AL5 2NU Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Wheatfield Avenue
    AL5 2NU Harpenden
    Hertfordshire
    British8575320001
    RIDEHALGH, Frank
    38 Scarborough Road
    FY8 3ES St Annes On Sea
    Lancashire
    Amministratore
    38 Scarborough Road
    FY8 3ES St Annes On Sea
    Lancashire
    British36400480001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILSON PECK PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Uk Estates Limited
    High Road
    N12 9RY London
    Britannia House
    England
    13 set 2016
    High Road
    N12 9RY London
    Britannia House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLimited Liability Company
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione00146523
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    WILSON PECK PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge deed
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4/5/6 market street,cambridge fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 14 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property known as 7-8 market street cambridge and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery the goodwill of any trade or business or other commercial activity by way of first floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 12 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclay house, 242-254 banbury road, summertown, oxford t/no. ON18883 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery..the benefit of all guarantees indemnities rent deposits..by way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights..assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 24 gen 2002
    Consegnato il 29 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property known as 1-7 blackett street and 2-8 pilgrim street newcastle upon tyne t/no. TY199570 fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities..floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 29 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 24 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property known as 200 and 201 high street lincoln title number LL99294 and LL97767 and secondly 27 bridge street stratford-upon-avon title number WK2944379 and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon. By way of floating charge all its land goods undertakings equipment and other items now or hereafter belonging to the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 28 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from sheafbank property trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property being land & buildings on the south side of john street salford t/n:- la 308734 assigns goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of set off
    Creato il 31 lug 1985
    Consegnato il 07 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 lug 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H old kingfield works cricket and road, sheffield, west yorkshire title no. Syk 49259.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 02 lug 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold, 178 and 180 west street, sheffield, south yorkshire. Title no. Syk 125680.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 02 lug 1985
    Consegnato il 12 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as canton works, 88 to 92 (even) west street, sheffield, south yorkshire. Title no syk 42612.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 17 gen 1985
    Consegnato il 31 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sums standings to the credit of any present/future account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 26 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H kingfield works, cricket inn road, shefield south yorkshire t/n syk 49259.
    Persone aventi diritto
    • N.M. Rothschild & Sons LTD.
    Transazioni
    • 26 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 26 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H canton works 88-92 west street, sheffiled south yorkshire t/n syk 42612.
    Persone aventi diritto
    • N.M. Rothschild & Sons LTD.
    Transazioni
    • 26 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 26 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H 178 and 180 west street sheffield, south yorkshire t/n syk 125680.
    Persone aventi diritto
    • N.M. Rothschild & Sons LTD.
    Transazioni
    • 26 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 27 nov 1981
    Consegnato il 02 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 13/15 parliament street harrogate north yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0