KINGSLEY CARDS LTD.

KINGSLEY CARDS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKINGSLEY CARDS LTD.
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01513540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KINGSLEY CARDS LTD.?

    • (2222) /

    Dove si trova KINGSLEY CARDS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KINGSLEY CARDS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINGSLEY CARDS (1980) LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    TRAILPANE LIMITED21 ago 198021 ago 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di KINGSLEY CARDS LTD.?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2006
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2007
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 ott 2004

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KINGSLEY CARDS LTD.?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al09 mag 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma23 mag 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KINGSLEY CARDS LTD.?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per KINGSLEY CARDS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Andrew Robert Ferguson come amministratore in data 03 set 2011

    1 pagineTM01

    Indirizzo di servizio dell'amministratore Mr Andrew Robert Ferguson modificato in 01513540 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH il 17 ott 2024

    1 pagineRP09

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    21 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 ott 2008

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 apr 2008

    23 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagine2.24B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    6 pagine2.39B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    41 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività

    32 pagine2.16B

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di KINGSLEY CARDS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEEDHAM, Phillip Geoffrey
    Scatterford Farm
    Newland
    GL16 8NG Coleford
    Gloucestershire
    Amministratore
    Scatterford Farm
    Newland
    GL16 8NG Coleford
    Gloucestershire
    British101206970001
    REEVES, William Thomas
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    3 The Coppins
    Wildwood
    ST17 4QB Stafford
    Staffordshire
    British93316550001
    EDWARDS, John
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    British3313700002
    MARTIN, Ben Andrew Douglas
    11 Lynton Grove
    Bradshaw
    HX2 9XN Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    11 Lynton Grove
    Bradshaw
    HX2 9XN Halifax
    West Yorkshire
    British97649410001
    MASON, Roger Malcolm
    1 Reddings Close
    Wendover
    HP22 6LG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Reddings Close
    Wendover
    HP22 6LG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British28112130001
    PARSLOE, Vivienne Dorothy
    Twin Peaks 20 New Road
    Marlow Bottom
    SL7 3NG Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    Twin Peaks 20 New Road
    Marlow Bottom
    SL7 3NG Marlow
    Buckinghamshire
    British28112120002
    SWATTEN, John David
    32 The Quays
    Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    32 The Quays
    Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    West Yorkshire
    British71001660002
    BAKER, Robin Martin
    The Old Priory
    Priest Bank Road, Kildwick
    BD20 9AE Keighley
    Yorkshire
    Amministratore
    The Old Priory
    Priest Bank Road, Kildwick
    BD20 9AE Keighley
    Yorkshire
    EnglandBritish89594350001
    BOTTOMLEY, Jeffrey
    Le Roccabella
    Avenue Princess Grace
    Mc 9800
    Monaco
    Amministratore
    Le Roccabella
    Avenue Princess Grace
    Mc 9800
    Monaco
    British71282090002
    BUSZARD, Fiona Patricia
    30 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    30 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British75161960001
    CARTER, Alan Leslie
    5 Gateway
    Harden
    BD16 1TG Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Gateway
    Harden
    BD16 1TG Bingley
    West Yorkshire
    British68381900002
    CARTER, Nicholas Michael
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    Amministratore
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    EnglandBritish120830070001
    EDWARDS, John
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Rectory View Pinfold Lane
    WF14 9JA Mirfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish3313700002
    FERGUSON, Andrew Robert
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    01513540 - Companies House Default Address
    Amministratore
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    01513540 - Companies House Default Address
    EnglandBritish116262420001
    FIELDING, Michael
    6 Hanover Terrace
    Regents Park
    NW1 4RJ London
    Amministratore
    6 Hanover Terrace
    Regents Park
    NW1 4RJ London
    EnglandBritish35062150001
    HOLMES, Christopher
    2 George Harrison Close
    L6 9HU Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    2 George Harrison Close
    L6 9HU Liverpool
    Merseyside
    British68381930001
    LEWIS, Glenn Ian
    1 Ormond Place
    NN14 1JL Isham
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Ormond Place
    NN14 1JL Isham
    Northamptonshire
    Great BritainBritish45713490001
    MARSHALL, Geoffrey Richard
    The Coach House 19 St Marys Road
    KT6 5EU Long Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Coach House 19 St Marys Road
    KT6 5EU Long Ditton
    Surrey
    British96978850001
    MASON, Roger Malcolm
    1 Reddings Close
    Wendover
    HP22 6LG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Reddings Close
    Wendover
    HP22 6LG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British28112130001
    MURGATROYD, Carl Richard
    5 Stone Cottage Aireview
    Sandbeds
    BD20 5LH Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Stone Cottage Aireview
    Sandbeds
    BD20 5LH Keighley
    West Yorkshire
    British71110540001
    NAYLOR, Ian
    3 Penfold Court
    Hellifield
    BD23 4LW Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Penfold Court
    Hellifield
    BD23 4LW Skipton
    North Yorkshire
    British113327610001
    NICHOLLS, Graham Edwin
    17 Middlebeck Drive
    Arnold
    NG5 8AL Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    17 Middlebeck Drive
    Arnold
    NG5 8AL Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish127794570001
    ORMSTON, Julie Lawson
    Tamlynn 8 Overdale Grange
    BD23 6AG Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tamlynn 8 Overdale Grange
    BD23 6AG Skipton
    North Yorkshire
    British28112160002
    ORR, David Malcolm
    Leeward 5 Townsend Reach
    Wharf Lane
    SL8 5RH Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Leeward 5 Townsend Reach
    Wharf Lane
    SL8 5RH Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish106181020001
    PARSLOE, Vivienne Dorothy
    Twin Peaks 20 New Road
    Marlow Bottom
    SL7 3NG Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Twin Peaks 20 New Road
    Marlow Bottom
    SL7 3NG Marlow
    Buckinghamshire
    British28112120002
    PHIPPS, Brian William
    Saintbury Grounds Farm
    Weston Road
    WR11 7QA Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Saintbury Grounds Farm
    Weston Road
    WR11 7QA Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish74725980004
    SWATTEN, John David
    32 The Quays
    Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    32 The Quays
    Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    West Yorkshire
    British71001660002

    KINGSLEY CARDS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 27 apr 2006
    Consegnato il 12 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured assets being the stock defined in a business and asset sale agreement,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aberdeen Asset Managers Limited in Its Capacity as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transazioni
    • 12 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 28 set 2005
    Consegnato il 30 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    £500,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The goods being 1 nsf thermo foil stamping press serial no 0008, 1 orwak model 5031 bailing machine serial no 8232756, 1 winkler and dunnebier type 81333 inserting machine serial no 12453 (1996) with compaq evo personal computer and associated equipment, for details of further goods charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 lug 2005
    Consegnato il 26 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aberdeen Asset Managers Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 16 ott 2003
    Consegnato il 23 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 x winkler and dunnebier type 81333 inserting machine, serial no. 12453 6) with compaq evo personal computer, monitor, keyboard and mouse and associated equipment, 1 x longford model cf 200-5 folding machine, serial no. 1304-82, 1 x heidelberg type gtp creasing and foiling press, serial no. GTP67163E together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation (or any amendments to them). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 07 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    £453,222 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The kora packmat machine VRM25 (s/no 2661 & 2662) and kora packmat machine VFM102 (s/n 2654 & 2655) together with all accessories and component parts and all improvements and renewals books manuals and all other documentation.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 mag 2000
    Consegnato il 19 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property mortaged or charged including; schneider type senator model 155MCV paper guillotine serial no 60720 Õ1988! complete with air tables; schneider type senator model 155MC2 paper guillotine serial no 60640 Õ1985! complete with air tables; 2 x splek type SL32-500 pallet hoists serial no 930 Õ1988! & 931 Õ1988!. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 mag 2000
    Consegnato il 19 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property mortgaged or charged including; envetron damping roller washer; magnavac air systems selvedge extraction system Õ1994! comprising extraction fan & ducting; 4 x printing trade services bottom numbering units Õ1 each on assets 40,41,42 above plus 1 spare!. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 02 ott 1986
    Consegnato il 03 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All & singular the chattels plant & machinery & items described in the schedule on reverse of form 395 dated 3/10/86.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 03 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 21 set 1986
    Consegnato il 07 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £556,350.17 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    By way of floating charge over all the undertaking and property whatsoever and wheresoever of the company both present and future including its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Vivienne Dorothy Parsloe
    • Jeffrey Bottomley
    • Roger Malcolm Mason
    Transazioni
    • 07 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 ott 1985
    Consegnato il 07 nov 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1983
    Consegnato il 07 dic 1983
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings at skipton, north yorkshire being or known as belle vue mills.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge was registered pursuant to an order of court dated 7/5/82
    Creato il 23 dic 1981
    Consegnato il 08 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H catsbrain farm, oakley. Buckinghamshire. Title no. Bm 42113.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1981
    Consegnato il 15 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H fieth mills, fieth street, skipton north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 20 ott 1980
    Consegnato il 28 ott 1980
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1980Registrazione di un'ipoteca

    KINGSLEY CARDS LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 apr 2006Inizio dell'amministrazione
    15 apr 2009Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Francis Graham Newton
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0