EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED

EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01513597
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OBLEC LIMITED21 ago 198021 ago 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da The School House 50 Brook Green London W6 7RR in data 16 mar 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 mar 2010

    LRESSP

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Mark Cohen il 31 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Caroline Ann Drake il 31 gen 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Jane Phillips come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Mccallum come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jonathan Mark Cohen come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DRAKE, Caroline Ann
    Old Bailey
    EC4M 7AF London
    5
    Segretario
    Old Bailey
    EC4M 7AF London
    5
    Other70982540001
    COHEN, Jonathan Mark
    Old Bailey
    EC4M 7AF London
    5
    Amministratore
    Old Bailey
    EC4M 7AF London
    5
    EnglandBritish131608080001
    GERRARD, Barry Alexander Ralph
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    United KingdomBritish188290005
    BAYLISS, Joshua
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    Segretario
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    British114409340001
    COOK, Janice Susan
    33 Stanley Road
    South Harrow
    HA2 8AY London
    Segretario
    33 Stanley Road
    South Harrow
    HA2 8AY London
    British58934320001
    GERRARD, Barry Alexander Ralph
    17 Mowbray Close
    MK43 8LF Bromham
    Bedfordshire
    Segretario
    17 Mowbray Close
    MK43 8LF Bromham
    Bedfordshire
    British188290001
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Segretario
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Segretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Segretario
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    British52485510001
    ABBOTT, Trevor Michael
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    British35278820001
    BURROUGHS, Ian Steven
    26 Mount Close
    RH10 7EF Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    26 Mount Close
    RH10 7EF Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish105323210001
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Amministratore
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    HALL, Susannah Mary Louise
    76 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    Amministratore
    76 Sutton Court
    Chiswick
    W4 3JF London
    British75930520004
    HILL, Mark Frederick David
    1 Birkbeck Road
    Ealing
    W5 4ES London
    Amministratore
    1 Birkbeck Road
    Ealing
    W5 4ES London
    British102025040001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Amministratore
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    MCCALLUM, Gordon Douglas
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    United KingdomBritish55294030006
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Amministratore
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    British70496800002
    PHILLIPS, Jane Elizabeth Margaret
    10 Hornminster Glen
    RM11 3XL Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    10 Hornminster Glen
    RM11 3XL Hornchurch
    Essex
    EnglandBritish85707450003
    WELSH, Peter Melvyn
    24 Peel Avenue
    Frimley
    GU16 8YT Camberley
    Surrey
    Amministratore
    24 Peel Avenue
    Frimley
    GU16 8YT Camberley
    Surrey
    British89403200001

    EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second charge
    Creato il 21 gen 1991
    Consegnato il 11 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Virgin Management Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 24 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 apr 1989
    Consegnato il 29 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 29 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 30 ott 1980
    Consegnato il 12 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. (See doc M11 for details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1980
    Consegnato il 03 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Specific equitable charge over the company's freehold and leasehold properties and the proceeds of sale thereof including fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 20 set 1980
    Consegnato il 26 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Someuel & Co LTD
    Transazioni
    • 26 set 1985Registrazione di un'ipoteca

    EURO-MAGNETIC PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 gen 2011Data di scioglimento
    09 mar 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Peter John Robertson Souster
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0