GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED

GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01519515
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arlington House
    Arlington Business Park
    RG7 4SA Theale, Reading Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARLINGTON BUSINESS PARKS LIMITED11 mar 198811 mar 1988
    ARLINGTON PROPERTY SERVICES LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    PORCHGABLE LIMITED30 set 198030 set 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 apr 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 17 dic 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 18 dic 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Robert Paul Reed come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di James Martin Cornell come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael O'sullivan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Pope come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANCOSEC LIMITED
    Arlington House
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Segretario
    Arlington House
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Hitchwood Barn
    Hitchwood Lane
    SG4 7RW Preston
    Hitchwood Barn
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Hitchwood Barn
    Hitchwood Lane
    SG4 7RW Preston
    Hitchwood Barn
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishTreasurer148803950001
    JOHNSTON, Andrew James
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    Amministratore
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChartered Surveyor131001620001
    REED, Robert Paul
    Arlington House
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4SA Reading
    Arlington House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Arlington House
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4SA Reading
    Arlington House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector Of Finance And Reporting148032280006
    BLACKWELL, Anne Christine
    18 Bettespol Meadows
    Redbourn
    AL3 7EW St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    18 Bettespol Meadows
    Redbourn
    AL3 7EW St Albans
    Hertfordshire
    British1216410001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Segretario
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Segretario
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    ALLEN, Godfrey Alwin
    45 Burnt Oak
    SL6 9RN Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    45 Burnt Oak
    SL6 9RN Cookham
    Berkshire
    BritishCompany Director5368530001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51921200001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant60464290003
    CHATER, Beth Salena
    Sycamore House
    Oxford Road, Chieveley
    RG20 8RT Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Sycamore House
    Oxford Road, Chieveley
    RG20 8RT Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant60464290001
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishBuilding Surveyor37099910001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor49654480002
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant10297860001
    JOHNSTON, Andrew James
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    Amministratore
    Langford
    GL7 3LF Nr Lechlade
    Langford Grange
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChartered Surveyor131001620001
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Amministratore
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    BritishFinance Director51579180001
    MURRAY, Nicholas Stuart Granville
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director29664370001
    O'SULLIVAN, Michael James
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    AustralianDirector109785090002
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Amministratore
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant29583660002
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritishChartered Accountant14448630001
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant49776690004
    RICHARDS, Windsor
    Sherwood
    New Road Shiplake
    RG9 3LG Henley On Thames
    Amministratore
    Sherwood
    New Road Shiplake
    RG9 3LG Henley On Thames
    BritishConstruction Director114419350001
    ROGERS, Hugh Edward
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    Amministratore
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    BritishChartered Engineer13156340003
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Amministratore
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director73972350001

    GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of charge
    Creato il 01 set 1993
    Consegnato il 03 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein,on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company of the bank's books.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 giu 1992
    Consegnato il 09 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or abacus developments limited to the chargee under the loan agreement and/or the debenture and/or any other security documents (as therein defined
    Brevi particolari
    All undertaking and contracts etc.. (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyariesas Agent and Trustee for Itself and the Benefici
    Transazioni
    • 09 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 lug 1991
    Consegnato il 05 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or abacus development limited to the chargee under the terms of this charge, the debenture and loan agreement both dated 10TH july 1990 and/or any other security documents (as defined).
    Brevi particolari
    By way of fixed & floating charge over all those particulars as detailed on form 395 & riders attached (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 05 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter to charge
    Creato il 25 giu 1991
    Consegnato il 03 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 lug 1990
    Consegnato il 17 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or abacus developemnts limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 10/7/90 and this deed.
    Brevi particolari
    All right title interest and benefits in the reading business park partnership (see form M395, ref m 512C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companybanks.)(As Agent and Trustee for Itself and The
    Transazioni
    • 17 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Partnership assignment
    Creato il 10 lug 1990
    Consegnato il 17 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the partnership (as defined) and/ orthe company to bankers trust company as agent and trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of the agreement of even date and the security documents (as therein defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined)
    Brevi particolari
    Assigns all the share and interest in the capital and assets of the partnership and the profits thereto.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 17 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Partnership assignment as evidenced by a statutary declaration dated 23/5/88
    Creato il 04 mag 1988
    Consegnato il 11 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 32,500,000 and all the moneys due or to become due from the company and reading business park partnership to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the banks named therein under the terms ofa loan agreement dated 4/5/88 and the security document as defined and under theterms of the charge
    Brevi particolari
    Assigned by way of security to the agent for itself and as agent trustee for itself and the banks all the share and interest in the capital and assets of the reading business park partnership and the profits thereto (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 11 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    As evidenced by a statutory declaration dated 23/5/88 debenture
    Creato il 04 mag 1988
    Consegnato il 11 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 32,500,000 debenture and all other moneys due or to become due from reading business park partnership to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the banks named therein under the terms of a loan agreement dated 4/5/88 and the security documents as defined and under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    First legal charge the land situate at theale, berkshire fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures & fittings) (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Trustee for Itself and the Banks.
    Transazioni
    • 11 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0