GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01519515 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Arlington House Arlington Business Park RG7 4SA Theale, Reading Berkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ARLINGTON BUSINESS PARKS LIMITED | 11 mar 1988 | 11 mar 1988 |
ARLINGTON PROPERTY SERVICES LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
PORCHGABLE LIMITED | 30 set 1980 | 30 set 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 12 apr 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 17 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 18 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Paul Reed come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di James Martin Cornell come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael O'sullivan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Pope come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCOSEC LIMITED | Segretario | Arlington House Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 111724450001 | |||||||
CORNELL, James Martin | Amministratore | Hitchwood Barn Hitchwood Lane SG4 7RW Preston Hitchwood Barn Hertfordshire England | England | British | Treasurer | 148803950001 | ||||
JOHNSTON, Andrew James | Amministratore | Langford GL7 3LF Nr Lechlade Langford Grange Gloucestershire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 131001620001 | ||||
REED, Robert Paul | Amministratore | Arlington House Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading Arlington House Berkshire England | England | British | Director Of Finance And Reporting | 148032280006 | ||||
BLACKWELL, Anne Christine | Segretario | 18 Bettespol Meadows Redbourn AL3 7EW St Albans Hertfordshire | British | 1216410001 | ||||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Segretario | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||
FERGUSON, Iain Donald | Segretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||
LYNE, Sarah Jane | Segretario | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||
READ, Jonathan David | Segretario | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||
ALLEN, Godfrey Alwin | Amministratore | 45 Burnt Oak SL6 9RN Cookham Berkshire | British | Company Director | 5368530001 | |||||
AUSTEN, Jonathan Martin | Amministratore | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | Director | 51921200001 | ||||
CHATER, Beth Salena | Amministratore | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 60464290003 | ||||
CHATER, Beth Salena | Amministratore | Sycamore House Oxford Road, Chieveley RG20 8RT Newbury Berkshire | British | Accountant | 60464290001 | |||||
DEIGMAN, Patrick | Amministratore | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Building Surveyor | 37099910001 | ||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Amministratore | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 49654480002 | ||||
DUFFIELD, David Mark Johnston | Amministratore | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 49654480002 | ||||
FERGUSON, Iain Donald | Amministratore | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 10297860001 | ||||
JOHNSTON, Andrew James | Amministratore | Langford GL7 3LF Nr Lechlade Langford Grange Gloucestershire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 131001620001 | ||||
MOHANLAL, Satish | Amministratore | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | Finance Director | 51579180001 | |||||
MURRAY, Nicholas Stuart Granville | Amministratore | Oak House 51 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 29664370001 | ||||
O'SULLIVAN, Michael James | Amministratore | Greenlawns 21 Broad Highway KT11 2RR Cobham Surrey | Australian | Director | 109785090002 | |||||
POPE, Nigel Howard | Amministratore | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | Chartered Accountant | 29583660002 | ||||
PRICE, Humphrey James Montgomery | Amministratore | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | Chartered Accountant | 14448630001 | ||||
PULSFORD, Jeffrey Mark | Amministratore | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 49776690004 | ||||
RICHARDS, Windsor | Amministratore | Sherwood New Road Shiplake RG9 3LG Henley On Thames | British | Construction Director | 114419350001 | |||||
ROGERS, Hugh Edward | Amministratore | 24 Sonning Meadows RG4 6XB Sonning Berkshire | British | Chartered Engineer | 13156340003 | |||||
VAUGHAN, Patrick Lionel | Amministratore | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 73972350001 |
GOODMAN BUSINESS PARKS (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge | Creato il 01 set 1993 Consegnato il 03 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from all or any of the companies named therein,on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company of the bank's books.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 30 giu 1992 Consegnato il 09 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or abacus developments limited to the chargee under the loan agreement and/or the debenture and/or any other security documents (as therein defined | |
Brevi particolari All undertaking and contracts etc.. (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 30 lug 1991 Consegnato il 05 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company and/or abacus development limited to the chargee under the terms of this charge, the debenture and loan agreement both dated 10TH july 1990 and/or any other security documents (as defined). | |
Brevi particolari By way of fixed & floating charge over all those particulars as detailed on form 395 & riders attached (see doc for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter to charge | Creato il 25 giu 1991 Consegnato il 03 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 lug 1990 Consegnato il 17 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or abacus developemnts limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 10/7/90 and this deed. | |
Brevi particolari All right title interest and benefits in the reading business park partnership (see form M395, ref m 512C for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Partnership assignment | Creato il 10 lug 1990 Consegnato il 17 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the partnership (as defined) and/ orthe company to bankers trust company as agent and trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of the agreement of even date and the security documents (as therein defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) | |
Brevi particolari Assigns all the share and interest in the capital and assets of the partnership and the profits thereto. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Partnership assignment as evidenced by a statutary declaration dated 23/5/88 | Creato il 04 mag 1988 Consegnato il 11 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 32,500,000 and all the moneys due or to become due from the company and reading business park partnership to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the banks named therein under the terms ofa loan agreement dated 4/5/88 and the security document as defined and under theterms of the charge | |
Brevi particolari Assigned by way of security to the agent for itself and as agent trustee for itself and the banks all the share and interest in the capital and assets of the reading business park partnership and the profits thereto (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
As evidenced by a statutory declaration dated 23/5/88 debenture | Creato il 04 mag 1988 Consegnato il 11 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 32,500,000 debenture and all other moneys due or to become due from reading business park partnership to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the banks named therein under the terms of a loan agreement dated 4/5/88 and the security documents as defined and under the terms of the charge. | |
Brevi particolari First legal charge the land situate at theale, berkshire fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures & fittings) (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0