CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED

CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01521006
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Abbey Orchard Street
    SW1P 2HT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES GROUP LIMITED31 dic 200131 dic 2001
    KENNEDY CONSTRUCTION GROUP LIMITED08 ott 198008 ott 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 mag 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 mag 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al17 mag 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT in data 03 ott 2018

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Carillion (Am) Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018

    2 paginePSC05

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 25 giu 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 18 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Nigel Paul Taylor come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Stephen William Hudson come amministratore in data 17 apr 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mag 2016

    Stato del capitale al 17 mag 2016

    • Capitale: GBP 218,800
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2015

    Stato del capitale al 18 mag 2015

    • Capitale: GBP 218,800
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Paul Taylor il 17 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen William Hudson il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee James Mills il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 02 mar 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY a Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR in data 02 mar 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2014

    Stato del capitale al 19 mag 2014

    • Capitale: GBP 218,800
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen William Hudson il 09 ago 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ATKINSON, Sarah Elizabeth
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    Segretario
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    British53216670002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Segretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Segretario
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    KIRKIN, Richard William
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Segretario
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    British1180700001
    LEE, Christopher Michael
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    Segretario
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    British133709330001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ATKINSON, Sarah Elizabeth
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    British53216670002
    BODDINGTON, Richard Stewart
    Quercus House Winsford Road
    Cholmondeston
    CW7 4DP Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    Quercus House Winsford Road
    Cholmondeston
    CW7 4DP Winsford
    Cheshire
    British15834890001
    CARNEY, Patrick
    22 Carrwood Road
    SK9 5DL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    22 Carrwood Road
    SK9 5DL Wilmslow
    Cheshire
    British27467650001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Amministratore
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    CARTER, Sholto Douglas Bowie
    103 Appleby Road
    LA9 6HE Kendal
    Cumbria
    Amministratore
    103 Appleby Road
    LA9 6HE Kendal
    Cumbria
    British27715730002
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    COCLIFF, Stephen Jeffrey
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    Amministratore
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    EnglandBritish125427070002
    DOUGHTY, Stuart John
    Bradley Farm House
    Kinlet
    DY12 3BU Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    Bradley Farm House
    Kinlet
    DY12 3BU Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish31394540001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Amministratore
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    HOUGH, Robert Eric
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritish38776360001
    HUDSON, Stephen William
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish78380050003
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Amministratore
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    JONES, Peter Rudulph
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandIrish173952430001
    KENNEDY, John Gerard
    7 Rivershill Gardens
    Halebarns
    WA15 0AZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    7 Rivershill Gardens
    Halebarns
    WA15 0AZ Altrincham
    Cheshire
    Irish58803900001
    KENNEDY, Kathleen
    Brooks Drive
    WA15 8TL Hale Barns
    Cheshire
    Amministratore
    Brooks Drive
    WA15 8TL Hale Barns
    Cheshire
    United KingdomIrish47720550002
    KENNEDY, Patrick James
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish47720560001
    KIRKIN, Richard William
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish1180700001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Amministratore
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    PARSONS, James Christopher
    Chudleigh 34 Arthog Road
    Hale
    WA15 0LY Altrincham
    Amministratore
    Chudleigh 34 Arthog Road
    Hale
    WA15 0LY Altrincham
    British1180670002
    REID, John Watson
    The Laurels Park Gates Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 7DF Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    The Laurels Park Gates Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 7DF Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish12949730002
    ROBERTSON, Alan Robert
    Little Bote House
    Etherington Hill
    TN3 0TN Speldhurst
    Kent
    Amministratore
    Little Bote House
    Etherington Hill
    TN3 0TN Speldhurst
    Kent
    British107595570001
    TAYLOR, Nigel Paul
    40 Melton Street
    NW1 2FD London
    One Euston Square
    United Kingdom
    Amministratore
    40 Melton Street
    NW1 2FD London
    One Euston Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish162715410001
    WILKINS, Andrew Michael
    PR25
    Amministratore
    PR25
    United KingdomBritish125411390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1367044
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 10 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Subject lying to the southwest side of union street hamilton t/n-lan 95859. subjects lying on the northwest side of goil avenue bellshill t/n-LAN90356.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1997
    Consegnato il 16 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Cash collateral security
    Creato il 13 ago 1997
    Consegnato il 15 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assign the charged account being the account of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums (in whatever currency) together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 1987
    Consegnato il 22 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land and buildings to the south-east side of chaddock lane astley tyldesley wigan greater manchester title no gm 387045 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 giu 1987
    Consegnato il 22 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land and buildings to the north west side of choddock lane tyldesley wigan greater manchester fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 ott 1983
    Consegnato il 07 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land forming park of mayo blooks drive halo barns trafford, gt manchester together with all fixture whatsoever now or at any time hereafter afflxed or attached to the property or any part therof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Transazioni
    • 07 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 27 ott 1981
    Consegnato il 29 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the sums due under a loan agreement dated 27 oct 1981
    Brevi particolari
    Motor vehicles,daimler sovereign hba 71V daimler sovereign mnc 935W, rolls royce silver spirit dpm 1C.
    Persone aventi diritto
    • Savings & Investment Bank & Limited
    Transazioni
    • 29 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 31 lug 1981
    Consegnato il 18 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and all property and assetspresent and future including goodwill bookdebts uncalled capital & all fixtures & fittings (inc. Trade fixtures & fittings) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 18 ago 1981Registrazione di un'ipoteca

    CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 apr 2018Data della petizione
    13 giu 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0