CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01521006 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES GROUP LIMITED | 31 dic 2001 | 31 dic 2001 |
| KENNEDY CONSTRUCTION GROUP LIMITED | 08 ott 1980 | 08 ott 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mag 2019 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 mag 2019 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mag 2018 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT in data 03 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion (Am) Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 25 giu 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Paul Taylor come amministratore in data 29 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen William Hudson come amministratore in data 17 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Paul Taylor il 17 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen William Hudson il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee James Mills il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 02 mar 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY a Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR in data 02 mar 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen William Hudson il 09 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Segretario | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Segretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Segretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Segretario | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Segretario | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Amministratore | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BODDINGTON, Richard Stewart | Amministratore | Quercus House Winsford Road Cholmondeston CW7 4DP Winsford Cheshire | British | 15834890001 | ||||||
| CARNEY, Patrick | Amministratore | 22 Carrwood Road SK9 5DL Wilmslow Cheshire | British | 27467650001 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Amministratore | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CARTER, Sholto Douglas Bowie | Amministratore | 103 Appleby Road LA9 6HE Kendal Cumbria | British | 27715730002 | ||||||
| COCKER, Neil David | Amministratore | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Amministratore | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| DOUGHTY, Stuart John | Amministratore | Bradley Farm House Kinlet DY12 3BU Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| GRICE, Ian Michael | Amministratore | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HOUGH, Robert Eric | Amministratore | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | 38776360001 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 78380050003 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Amministratore | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Peter Rudulph | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KENNEDY, John Gerard | Amministratore | 7 Rivershill Gardens Halebarns WA15 0AZ Altrincham Cheshire | Irish | 58803900001 | ||||||
| KENNEDY, Kathleen | Amministratore | Brooks Drive WA15 8TL Hale Barns Cheshire | United Kingdom | Irish | 47720550002 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Amministratore | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| KIRKIN, Richard William | Amministratore | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | England | British | 1180700001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Amministratore | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| PARSONS, James Christopher | Amministratore | Chudleigh 34 Arthog Road Hale WA15 0LY Altrincham | British | 1180670002 | ||||||
| REID, John Watson | Amministratore | The Laurels Park Gates Drive Cheadle Hulme SK8 7DF Cheadle Cheshire | England | British | 12949730002 | |||||
| ROBERTSON, Alan Robert | Amministratore | Little Bote House Etherington Hill TN3 0TN Speldhurst Kent | British | 107595570001 | ||||||
| TAYLOR, Nigel Paul | Amministratore | 40 Melton Street NW1 2FD London One Euston Square United Kingdom | United Kingdom | British | 162715410001 | |||||
| WILKINS, Andrew Michael | Amministratore | PR25 | United Kingdom | British | 125411390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Am) Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 29 ago 1997 Consegnato il 10 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Subject lying to the southwest side of union street hamilton t/n-lan 95859. subjects lying on the northwest side of goil avenue bellshill t/n-LAN90356. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 ago 1997 Consegnato il 16 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Cash collateral security | Creato il 13 ago 1997 Consegnato il 15 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Assign the charged account being the account of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums (in whatever currency) together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 giu 1987 Consegnato il 22 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-land and buildings to the south-east side of chaddock lane astley tyldesley wigan greater manchester title no gm 387045 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 giu 1987 Consegnato il 22 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-land and buildings to the north west side of choddock lane tyldesley wigan greater manchester fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 ott 1983 Consegnato il 07 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land forming park of mayo blooks drive halo barns trafford, gt manchester together with all fixture whatsoever now or at any time hereafter afflxed or attached to the property or any part therof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 27 ott 1981 Consegnato il 29 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing the sums due under a loan agreement dated 27 oct 1981 | |
Brevi particolari Motor vehicles,daimler sovereign hba 71V daimler sovereign mnc 935W, rolls royce silver spirit dpm 1C. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 lug 1981 Consegnato il 18 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge undertaking and all property and all property and assetspresent and future including goodwill bookdebts uncalled capital & all fixtures & fittings (inc. Trade fixtures & fittings) fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CARILLION UTILITY SERVICES GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0