ABBERPLACE LIMITED
Panoramica
Nome della società | ABBERPLACE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01521051 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABBERPLACE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ABBERPLACE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ABBERPLACE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BRADGRANGE PACKAGING LIMITED | 23 mar 1992 | 23 mar 1992 |
ABERPLACE LIMITED | 09 ott 1980 | 09 ott 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABBERPLACE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ABBERPLACE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Eric Otto come amministratore in data 29 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Alexander Gillies come amministratore in data 29 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Eric Otto come amministratore in data 31 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen David Waugh come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen David Waugh come amministratore in data 30 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn Richard Powell come amministratore in data 30 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David White come amministratore in data 04 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Varie Aud res sect 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 4 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Michael John Fitchford come amministratore in data 18 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ABBERPLACE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWELL, Martyn Richard | Segretario | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | British | 38707060002 | ||||||
FITCHFORD, Andrew Michael John | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | England | British | Chartered Accountant | 202834830001 | ||||
GILLIES, David Alexander | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | England | British | Ceo | 263845050001 | ||||
BRETON, Angus Roy Mackenzie | Segretario | The Pond House Woolstone SN7 7QL Faringdon Oxfordshire | British | Solicitor | 36162870005 | |||||
COOK, Jonathan Charles | Segretario | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | Accountant | 72559760001 | |||||
LYNE, Colin Andrew | Segretario | The Haven Featherbed Lane Pathlow CV37 0ER Stratford Warwickshire | British | Director | 49615160001 | |||||
ROWLAND, Stephen | Segretario | 114 Canterbury Road GU14 6QN Farnborough Hampshire | British | Director | 4796000001 | |||||
WINTERS, Geoffrey David | Segretario | Tavistock House Mearse Lane B45 8HL Barnt Green Worcester | British | Director | 42524380002 | |||||
BRETON, Angus Roy Mackenzie | Amministratore | The Pond House Woolstone SN7 7QL Faringdon Oxfordshire | England | British | Solicitor | 36162870005 | ||||
COOK, Jonathan Charles | Amministratore | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | Accountant | 72559760001 | |||||
DIXON, Mark Robert Graham | Amministratore | Harperley Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull | United Kingdom | British | Director | 51467220003 | ||||
JOHNSON, Richard Stuart | Amministratore | Braxfield House Charingworth GL55 6XU Chipping Campden Gloucestershire | British | Director | 6420800001 | |||||
LYNE, Colin Andrew | Amministratore | The Haven Featherbed Lane Pathlow CV37 0ER Stratford Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 49615160001 | ||||
OTTO, Eric | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | Netherlands | Dutch | Director | 253838980001 | ||||
POWELL, Martyn Richard | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | United Kingdom | British | Director | 38707060002 | ||||
ROWLAND, Stephen | Amministratore | 114 Canterbury Road GU14 6QN Farnborough Hampshire | British | Company Director | 4796000001 | |||||
WAUGH, Stephen David | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | England | British | Ceo | 60459250003 | ||||
WHITE, David | Amministratore | Amber Way Halesowen B62 8WG West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 1596440002 | ||||
WINTERS, Geoffrey David | Amministratore | Tavistock House Mearse Lane B45 8HL Barnt Green Worcester | British | Director | 42524380002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ABBERPLACE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilleshall Building Products Ltd | 06 apr 2016 | Amberway B62 8WG Halesowen 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ABBERPLACE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 10 ott 1990 Consegnato il 16 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 apr 1989 Consegnato il 08 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H premises at brook street, redditch, hereford and worcester title no hw 67173. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 06 dic 1988 Consegnato il 09 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 apr 1987 Consegnato il 23 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H situate on the south side of brook street redditch in the county of herford and worcester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 09 apr 1987 Consegnato il 16 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property at brook street redditch in the county of hereford and worcester having on area of approx 2.40 acres, with all buildings and fixtures and the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 28 ott 1986 Consegnato il 29 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £75,000 | |
Brevi particolari Floating charge over undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 01 set 1986 Consegnato il 19 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Sandretto and toshba machinery as specified on the form M395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Gurantee & debenture | Creato il 27 feb 1986 Consegnato il 14 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or brystal ware products (hereford) limited | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 18 ott 1983 Consegnato il 25 ott 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of or arizing out of a counter-inderminity executed by the company in respect of a deed dated 2 sept 1983 whereby the bank guaranteed the payment of £60,000 do st. James's gato holdings limited | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standig to the standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated aberlace limited current account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 giu 1983 Consegnato il 02 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £40,000 | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 20 lug 1981 Consegnato il 06 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The injection moulding equipment as identified on the form....(see doc M17 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 mag 1981 Consegnato il 08 giu 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital & all buildings fixtures ninc trade fixturese fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ABBERPLACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0