ICG CLEANING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ICG CLEANING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01523784 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ICG CLEANING LIMITED?
- Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova ICG CLEANING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ground Floor Suite River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Kent |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ICG CLEANING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRIAN WINDER (GENERAL CLEANING CONTRACTORS) LIMITED | 22 ott 1980 | 22 ott 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ICG CLEANING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ICG CLEANING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti | 8 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come segretario in data 28 set 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Stephen Levine come amministratore in data 28 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Ian Saunders come amministratore in data 28 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Saunders come segretario in data 28 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come amministratore in data 09 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Scott Dudley come amministratore in data 12 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Aero Works Adair Street Manchester M1 2NQ* in data 23 ago 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ICG CLEANING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILES, Simon Kenneth | Segretario | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | 201339540001 | |||||||
| GILES, Simon Kenneth | Amministratore | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 196768780001 | |||||
| LEVINE, Jonathan Stephen | Amministratore | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 19162600001 | |||||
| DOWE, Stephen William | Segretario | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | British | 88908400002 | ||||||
| MCGIVERN, James Patrick | Segretario | 17 Acre Lane Heswall CH60 1UN Wirral Merseyside | British | 120346770001 | ||||||
| SAUNDERS, Mark | Segretario | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | 167362110001 | |||||||
| SCOBIE, James Martin | Segretario | Eastcote BR6 0AU Orpington 1 Kent England | 149576490001 | |||||||
| STRATFORD, Frederick | Segretario | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | 162167600001 | |||||||
| WINDER, Sheila Anne | Segretario | Jack House Farm Brogden Lane Barnoldswick BB8 5XF Colne Lancashire | British | 27580790001 | ||||||
| BOYLE, Eugene | Amministratore | Teach Ban Parkside Drive Whittle Le Woods PR6 7PL Chorley | England | British | 106717430001 | |||||
| DOWE, Stephen William | Amministratore | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 88908400002 | |||||
| DUDLEY, Scott | Amministratore | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 166551090001 | |||||
| HARDY-WILSON, Nigel Andrew | Amministratore | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | England | British | 149590930001 | |||||
| HOWROYD, David Rowan | Amministratore | Bay Tree House East Street TN20 6TY Mayfield East Sussex | British | 72333480002 | ||||||
| MCGIVERN, James Patrick | Amministratore | 17 Acre Lane Heswall CH60 1UN Wirral Merseyside | British | 120346770001 | ||||||
| PICKUP, James | Amministratore | Crooklands Farm Goosnargh Lane Goosnargh PR3 2JU Preston Lancashire | British | 35926750001 | ||||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Amministratore | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 139588670003 | |||||
| SCOBIE, James Martin | Amministratore | 1 Eastcote BR6 0AU Orpington Kent | United Kingdom | British | 73982880001 | |||||
| STRATFORD, Frederick Anthony | Amministratore | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | United Kingdom | British | 151871680001 | |||||
| WINDER, Brian | Amministratore | Jack House Farm Brogden Lane Barnoldswick BB8 5XF Colne Lancashire | British | 27580780001 | ||||||
| WINDER, Sheila Anne | Amministratore | Jack House Farm Brogden Lane Barnoldswick BB8 5XF Colne Lancashire | British | 27580790001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ICG CLEANING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Roger Leonard Burdett | 06 apr 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Jonathan Stephen Levine | 06 apr 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr David Mundell | 06 apr 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Simon Giles | 06 apr 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
ICG CLEANING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 ott 2008 Consegnato il 05 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed & floating charge | Creato il 30 ott 2008 Consegnato il 04 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 ott 2008 Consegnato il 04 nov 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 lug 2005 Consegnato il 22 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 09 mag 1988 Consegnato il 12 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 22 lug 1985 Consegnato il 26 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Westhill methodist church accrington road, burnley lancashire t/n:- la 283329 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 feb 1983 Consegnato il 12 feb 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H - westhill methodist church, accrington road, burnley, lancs. T.n- la 282329.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0