ICG CLEANING LIMITED

ICG CLEANING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàICG CLEANING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01523784
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ICG CLEANING LIMITED?

    • Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ICG CLEANING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ground Floor Suite River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ICG CLEANING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRIAN WINDER (GENERAL CLEANING CONTRACTORS) LIMITED22 ott 198022 ott 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di ICG CLEANING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ICG CLEANING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2016

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come segretario in data 28 set 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Jonathan Stephen Levine come amministratore in data 28 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Ian Saunders come amministratore in data 28 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Saunders come segretario in data 28 set 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2015

    Stato del capitale al 01 giu 2015

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come amministratore in data 09 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Dudley come amministratore in data 12 feb 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 feb 2014

    Stato del capitale al 25 feb 2014

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Aero Works Adair Street Manchester M1 2NQ* in data 23 ago 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ICG CLEANING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    201339540001
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish196768780001
    LEVINE, Jonathan Stephen
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish19162600001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    British88908400002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Segretario
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    SAUNDERS, Mark
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    167362110001
    SCOBIE, James Martin
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    Segretario
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    149576490001
    STRATFORD, Frederick
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Segretario
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    162167600001
    WINDER, Sheila Anne
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    Segretario
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    British27580790001
    BOYLE, Eugene
    Teach Ban
    Parkside Drive Whittle Le Woods
    PR6 7PL Chorley
    Amministratore
    Teach Ban
    Parkside Drive Whittle Le Woods
    PR6 7PL Chorley
    EnglandBritish106717430001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish88908400002
    DUDLEY, Scott
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish166551090001
    HARDY-WILSON, Nigel Andrew
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    EnglandBritish149590930001
    HOWROYD, David Rowan
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    British72333480002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    PICKUP, James
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    British35926750001
    SAUNDERS, Mark Ian
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish139588670003
    SCOBIE, James Martin
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    Amministratore
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    United KingdomBritish73982880001
    STRATFORD, Frederick Anthony
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aero Works
    United KingdomBritish151871680001
    WINDER, Brian
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    Amministratore
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    British27580780001
    WINDER, Sheila Anne
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    Amministratore
    Jack House Farm Brogden Lane
    Barnoldswick
    BB8 5XF Colne
    Lancashire
    British27580790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ICG CLEANING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Roger Leonard Burdett
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Jonathan Stephen Levine
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr David Mundell
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Simon Giles
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    ICG CLEANING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 05 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transazioni
    • 05 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 22 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 mag 1988
    Consegnato il 12 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 lug 1985
    Consegnato il 26 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Westhill methodist church accrington road, burnley lancashire t/n:- la 283329 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1983
    Consegnato il 12 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - westhill methodist church, accrington road, burnley, lancs. T.n- la 282329.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0