IDENTRUST IDENTITIES LIMITED

IDENTRUST IDENTITIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIDENTRUST IDENTITIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01526540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dukes Court
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASSA ABLOY MANAGEMENT SERVICES LIMITED24 ott 200224 ott 2002
    GRORUD INTERNATIONAL LIMITED02 feb 198702 feb 1987
    GRORUD INTERNATIONAL (SALES) LIMITED27 giu 198427 giu 1984
    GRORUD CODE SALES LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    FANBOTTLE LIMITED05 nov 198005 nov 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Assa Abloy Ab come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 288 Bishopsgate 288 Bishopsgate, 3 Floor, London, EC2M 4QP a Dukes Court Duke Street Woking GU21 5BH in data 04 apr 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr. Rodney Glass come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony Michael Ball come amministratore in data 18 lug 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2016

    Stato del capitale al 23 giu 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Mr. Anthony Michael Ball come amministratore in data 04 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Karen Jensen Wendel come amministratore in data 19 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Laura Crumley come amministratore in data 19 feb 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2015

    Stato del capitale al 23 lug 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Karen Jensen Wendel come amministratore in data 05 mar 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Assa Abloy Ltd, School Street, Willenhall, West Midlands, WV13 3PW a Dukes Court Duke Street Woking GU21 5BH in data 23 lug 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Graham Penter come segretario in data 05 mar 2015

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRUMLEY, Laura Lynn
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    Amministratore
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    United StatesAmerican205473010001
    GLASS, Rodney, Mr.
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    Amministratore
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    United StatesAmerican214944290001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Segretario
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    British57393440002
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Segretario
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    British1796200002
    MASON, Philip John
    32 Fallsway
    DH1 1AZ Durham
    Segretario
    32 Fallsway
    DH1 1AZ Durham
    British111990750002
    PENTER, Graham
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    Segretario
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    183815180001
    STERN, Alexander Paul
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    177777950001
    WAKEMAN, Martyn Gordon David
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    Segretario
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    British73175570001
    ANGELL-HANSEN, Tor
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    Norwegian47036160001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritish57393440002
    BALL, Anthony Michael, Mr.
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    Amministratore
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    UsaAmerican206372470001
    BRATZ, Bjor Olaf
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    Amministratore
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    Norwegian27403290001
    BRATZ, Jens Halvard
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    Amministratore
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    Norwegian8335430001
    BRATZ, Ragnvald
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    Amministratore
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    Norwegian8886200001
    BROWNING, Christopher David
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritish177705260001
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Amministratore
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    British1796200002
    JOHANSSON, Hans
    Estbrotevagen 14
    127 41 Skarholmen
    Sweden
    Amministratore
    Estbrotevagen 14
    127 41 Skarholmen
    Sweden
    Swedish99491810001
    MIDDLETON, John Linley
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandSouth Africian136763720002
    MONSTER, Bjorn
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    Norwegian27380790001
    NORCOTT, Geoffrey
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Australian76193090001
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Norwegian47036280001
    SANDOY, Karl Halvard
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    Norwegian41615610001
    SASSE, Justin Andrew
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritish108040460001
    SODERGREN, Carl Ulf
    Bokvagen 12
    133 35 Saltsjobaden
    Sweden
    Amministratore
    Bokvagen 12
    133 35 Saltsjobaden
    Sweden
    Swedish103189740001
    VANN, Neil Arthur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritish135687720001
    VON SYDOW, Patrik Christian
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    Amministratore
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    EnglandSwedish102016580001
    WAKEMAN, Martyn Gordon David
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish73175570001
    WENDEL, Karen Jensen
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    United Kingdom
    Amministratore
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    United Kingdom
    UsaUnited States337696040001
    WIESENFELD, Itzhak
    Units 3-4 Zk Park
    23 Commerce Way
    CR0 4ZS Croydon
    Assa Abloy Emea
    England
    England
    Amministratore
    Units 3-4 Zk Park
    23 Commerce Way
    CR0 4ZS Croydon
    Assa Abloy Emea
    England
    England
    United KingdomBritish,Israeli113124340002
    ASSA ABLOY LIMITED
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    Amministratore
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    71976250002

    Chi sono le persone con controllo significativo di IDENTRUST IDENTITIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Assa Abloy Ab
    107 23 Stockholm
    107 23 PO BOX 7034o
    Sweden
    06 apr 2016
    107 23 Stockholm
    107 23 PO BOX 7034o
    Sweden
    No
    Forma giuridicaAb Public Limited Liability Company
    Paese di registrazioneSweden
    Autorità legaleSweden
    Luogo di registrazioneStockholm
    Numero di registrazione556059-3575
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental group cross guarantee indemnity and debenture
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 14 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Brevi particolari
    See form 3952 ref M148. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norske Bank As
    Transazioni
    • 14 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Den norske bank as
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 28 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Brevi particolari
    See form 395 ref M496C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norske Bank As
    Transazioni
    • 28 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group cross guarantee indemnity and debenture
    Creato il 28 feb 1991
    Consegnato il 08 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norsen Bank as London Branch.
    Transazioni
    • 08 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 dic 1988
    Consegnato il 03 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to a facility letter dated 16/12/88 and this debenture on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bergen Bank a/S
    Transazioni
    • 03 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 apr 1988
    Consegnato il 17 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from ground holdings (UK) limited to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital rights and securites.
    Persone aventi diritto
    • Bergen Bank
    Transazioni
    • 17 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 07 set 1981
    Consegnato il 15 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts due owing to or incurred to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0