BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED

BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01528286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Ark
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BENCHMARK CAPITAL LIMITED30 giu 198630 giu 1986
    MANSON PROPERTIES LIMITED14 nov 198014 nov 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 26 giu 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    31 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Marfleet come amministratore in data 02 lug 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Graham Frederick Boyd Palmer come amministratore in data 02 lug 2012

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Marfleet il 18 mag 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Stephen Roy Slocombe il 15 mag 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Roy Slocombe il 15 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Stephen Roy Slocombe come amministratore in data 03 ott 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ilaria Jane Del Beato come amministratore in data 03 ott 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Manuel Uria Fernandez come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Nomina di Ms Ilaria Jane Del Beato come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Gatiss come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Thomas Marfleet il 11 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian William Gatiss il 11 ott 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Segretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    British55097590003
    PALMER, Graham Frederick Boyd
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish170304850001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomEnglish151593900001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Segretario
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    British117898690002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    NORMAN, Andrew Peter Livesay
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    Segretario
    Little Pitts
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    British76545500001
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Segretario
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    WONG, Wing Yooi
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Segretario
    10 Bluebell Close
    SE26 6SN London
    Malaysian1541370001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Amministratore
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Swedish98463110005
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Amministratore
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    CULLIS, John Storrs
    10 Killyon Road
    SW8 2XT London
    Amministratore
    10 Killyon Road
    SW8 2XT London
    British65647610001
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Amministratore
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    KEMPNER, Nigel Justin
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bix Field
    Bix
    RG9 6BW Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish170036770001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001
    PEARSON, William James
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    Amministratore
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    United KingdomBritish133539850001
    QUEK, Leng Chan
    12th Floor,1a Jalan Stonor
    50450 Kuala Lumpur
    Malaysia
    Amministratore
    12th Floor,1a Jalan Stonor
    50450 Kuala Lumpur
    Malaysia
    Malaysian25169920002
    URIA FERNANDEZ, Manuel
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomSpanish123133150001
    WONG, Kwai Choy
    9 Daylesford Avenue
    SW15 5QR London
    Amministratore
    9 Daylesford Avenue
    SW15 5QR London
    United KingdomMalaysian31975980004

    BENCHMARK DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 15 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement dated 17TH may 1996 and the debenture as amended by the supplemental deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement dated 27TH june 1996 pursuant to which the bank agreed to make available to the company (under the guarantee of the guarantor) a loan facility of up to £2,000,000 and the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1996
    Consegnato il 18 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the loan agreement dated 17TH may 1996 and this debenture
    Brevi particolari
    L/H property k/a spirella house 266-270 (even numbers) regent street and 249 oxford street london W1 and the proceeds of sale thereof and all buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1991
    Consegnato il 13 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Camden house, the parade, birmingham west midlands title no wm 482148.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 07 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill buildings fixtures fixed plant and machinery land k/a the old school, 20, hampden gurney street london W1.
    Persone aventi diritto
    • First National Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1990
    Consegnato il 02 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Camden house parade birmingham west midlands with all addition and fixtures whatsoever. (Please see doc 395/m/392/C2/8 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Mount Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 02 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    A registered charge
    Creato il 22 feb 1990
    Consegnato il 26 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a camden house the parade, birmingham t/no wm 482148.
    Persone aventi diritto
    • N M B Postbank Groep N.V.
    Transazioni
    • 26 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Camden house parade birmingham west midlands. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Mount Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    Assignment
    Creato il 20 giu 1989
    Consegnato il 23 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 15/6/89 and or this charge
    Brevi particolari
    All the company right title and interest in all sums payable under any leases or tenancies of camden house the parade birmingham t/no wm 212150 see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nederlandsche Middenstands Bank N.V
    Transazioni
    • 23 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1989
    Consegnato il 23 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H camden house the parade birmingham t/no. Wm 212150.
    Persone aventi diritto
    • Nederlandache Middenstands Bank N.V.
    Transazioni
    • 23 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 mag 1989
    Consegnato il 06 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings k/a hampden gurney school hampden gurney st and the basement & ground floors of 17 seymour place london W1. (See form 395 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • First National Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 18 mag 1989
    Consegnato il 06 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the whole of the undertaking & all the property & assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • First National Commercial Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1989
    Consegnato il 14 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H property k/a old school site briar road twickenham title no. Sgl 75303 together with fixed machinery bldgs etc floating charge whatsoever & whensoever present & future (see form 395 m 87). undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Property Lending Trust PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1988
    Consegnato il 21 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 13 northburgh street, L.B. of islington. Title no ngl 623843 building materials. (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited.
    Transazioni
    • 21 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1981
    Consegnato il 05 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H- arndale house, 1/16, victoria road, washington, tyne & wear, having an area of approx. 3,893 sq. Yds.
    Persone aventi diritto
    • Edward Manson & Company Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1981
    Consegnato il 27 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 to 16 electric parade seven kings road ilford essex. Title no LN253740. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with the goodwill of any business or trade carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Edward Manson & Company Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0