KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01529162
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MEDIPLAN ENGINEERING LIMITED19 nov 198019 nov 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 gen 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 18/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2016

    Stato del capitale al 27 gen 2016

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Flowers il 13 mar 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 gen 2015

    Stato del capitale al 02 gen 2015

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Michael James Flowers come amministratore in data 24 lug 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Segretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Amministratore
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    HINCHCLIFFE, Alan
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    Amministratore
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    EnglandBritish86931130002
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Amministratore
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    United KingdomBritish42841660001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Amministratore
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    POLASHEK, Robert Alister
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68036570001
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2244623
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 mar 1993
    Consegnato il 31 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mar 1993
    Consegnato il 31 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a woodthorpe nhouse clapgate lane quinton birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 1993
    Consegnato il 29 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises at clapgate lane woodthorpe house woodgate valley birmingham together with all fixtures and fittings now or at any time herafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill of the business to the bank.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge,
    Creato il 10 set 1992
    Consegnato il 11 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC.
    Transazioni
    • 11 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1987
    Consegnato il 24 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a woodthorpe house, clapgate lane, woodgate valley, birmingham, west midlands title no wm 247670.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1983
    Consegnato il 10 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold woodthorpe house, clapgate lane halesowen west midlands title no wm 247670.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 16 nov 1982
    Consegnato il 19 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge on the book debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 05 apr 1982
    Consegnato il 08 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Freehold land floating to clapgate road, quinton, birmingham.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 feb 1982
    Consegnato il 23 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company & and/or sirebeck limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaing and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0