NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01530074
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED18 ott 199918 ott 1999
    STALWART RESIDENTIAL LIMITED22 nov 199422 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 22 ago 2014

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mag 2014

    Stato del capitale al 29 mag 2014

    • Capitale: GBP 721,874
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    25 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Auth to allot shares & duty to avoid conflicts of interest 24/06/2013
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Minimum number of directors is one 24/06/2013
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    5 pagineMR04

    Cessazione della carica di Roger Craine come amministratore in data 04 ott 2010

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Charles Woodcock come amministratore in data 04 ott 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roger Craine il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAKESPEARE, Paul
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Segretario
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    British150997870001
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    Segretario
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    British69321020002
    DUGGAN, Helen
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    Segretario
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    British67744330001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Segretario
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    HARDING, Barrington Howard
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    Segretario
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    British11466730001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    PEARSON, Michael Adrian
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    Segretario
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    British59751140001
    TEMPLETON, William James, Dr
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Segretario
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    New Zealander27024160001
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Segretario
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    Segretario
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    British87931760001
    ARTHUR, Richard
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    Amministratore
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    British71058650001
    BARRETT, Peter
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    Amministratore
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    British75515090001
    BARTLETT, John Leonard
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    British14120450001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish150997870001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritish106900580001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrish63716360005
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Amministratore
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    British88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    British21933520001
    DICKINSON, Stephen
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    British14120430001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Amministratore
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    American78292660001
    DOWNEY, Paul Martin
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    British10360260002
    EVANS, David Thomas James
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish62761080001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    GIRLING, Michael
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    British63304110001
    HAMMOND, Anthony
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    British52752380001
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish79961770002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritish13105310003
    HUGHFF, Victor William
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    British6622110001
    MCLAY, William Morrison
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    Amministratore
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    British54996780001
    MORGAN, Christopher
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    Amministratore
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    United KingdomBritish33875890001
    NARRAWAY, Nicholas William
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    British72113010001
    RAAB, Dennis Lynn
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    American48186120003

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 mar 1997
    Consegnato il 09 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995
    Brevi particolari
    L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 09 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 1996
    Consegnato il 30 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture)
    Brevi particolari
    2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transazioni
    • 30 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 nov 1995
    Consegnato il 30 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transazioni
    • 30 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 1995
    Consegnato il 05 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture)
    Brevi particolari
    8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transazioni
    • 05 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 06 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture
    Brevi particolari
    The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 06 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security account agreement
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Faciltiy Agreement))
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Collection account agreement
    Creato il 24 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 lug 1981
    Consegnato il 13 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1981Registrazione di un'ipoteca

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 ago 2014Inizio della liquidazione
    26 dic 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0