AF REALISATIONS LIMITED

AF REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAF REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01531702
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AF REALISATIONS LIMITED?

    • fabbricazione di elementi di fissaggio e prodotti per macchine a vite (25940) / Industrie manifatturiere
    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere
    • Commercio all'ingrosso di ferramenta, attrezzature per impianti idraulici e di riscaldamento e forniture (46740) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova AF REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Moorend House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AF REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANDREWS FASTENERS LIMITED07 nov 198307 nov 1983
    ANDREWS TOOLS AND FASTENERS (LEEDS) LTD31 dic 198131 dic 1981
    DAYAWAY LIMITED02 dic 198002 dic 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di AF REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per AF REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    8 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ago 2019

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ago 2018

    25 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    15 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagineAM22

    Cessazione della carica di Joanne Denham come segretario in data 01 mar 2017

    2 pagineTM02

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 gen 2017

    9 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 lug 2016

    9 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 gen 2016

    9 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 lug 2015

    16 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    33 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 8 Latchmore Park Latchmore Road Leeds Yorkshire LS12 6DN a Moorend House Snelsins Lane Cleckheaton BD19 3UE in data 28 gen 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed andrews fasteners LIMITED\certificate issued on 19/01/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 gen 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 gen 2015

    RES15

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di AF REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAREY, Michael Robson
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Moorend House
    Amministratore
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Moorend House
    EnglandBritish110593220002
    CONNER, Eileen
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    Segretario
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    British89546940001
    DENHAM, Joanne
    Camberley Way
    Pudsey
    LS28 8QX Leeds
    19
    West Yorkshire
    Segretario
    Camberley Way
    Pudsey
    LS28 8QX Leeds
    19
    West Yorkshire
    British188654670001
    HAGUE, David Michael
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    Segretario
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    British45671950001
    HALL, Robert John
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    British76827960001
    KRAUSE, Patricia
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    Segretario
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    British88921990001
    LAWTON, Kirsten
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British50045660001
    RIDGEWAY, Kevin Stuart
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    British73705320001
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    SPEDDING, Gary James
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    Segretario
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    British76827940001
    BATTENSBY, Mark
    36 Valley Road
    Bramley
    LS13 1EZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    36 Valley Road
    Bramley
    LS13 1EZ Leeds
    West Yorkshire
    British76827890001
    BUDD, Jonathan William
    1 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    1 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    British14530230001
    GEARTY, Anthony John
    Long Acres
    Poole Lane
    LS25 5JU Burton Salmon
    West Yorkshire
    Amministratore
    Long Acres
    Poole Lane
    LS25 5JU Burton Salmon
    West Yorkshire
    EnglandIrish127463800002
    GRINDY, Roger Sydney
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Amministratore
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British8369140001
    HAGUE, David Michael
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    Amministratore
    Applecroft Spoonley Gate Rudge
    Pattingham
    WV6 7ED Wolverhampton
    British45671950001
    HALL, Robert John
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    52 West End Road
    Epworth
    DN9 1LB Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish76827960001
    KRAUSE, Patricia
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    42 King Ecgbert Road
    Dore
    S17 3QR Sheffield
    Yorkshire
    United KingdomBritish88921990001
    LOVERIDGE, Keith
    4 Swannington Close
    Whitehill Cantley
    DN4 6UA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    4 Swannington Close
    Whitehill Cantley
    DN4 6UA Doncaster
    South Yorkshire
    British76827920001
    MCINNES, Bruce Gordon, Doctor
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    Amministratore
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    British2311870001
    PANTRY, Malcolm Swaine
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    British37363480001
    PERKINS, John Anthony
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    Amministratore
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    Irish1809090001
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    SMITH, David Dallas
    44 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QJ London
    Amministratore
    44 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QJ London
    British36289330001
    SPEDDING, Gary James
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    Amministratore
    3 Alderley Close
    SK12 1XA Poynton
    Cheshire
    British76827940001
    SURR, Robin
    Manor Road
    S60 5HF Brinsworth
    12
    South Yorkshire
    Amministratore
    Manor Road
    S60 5HF Brinsworth
    12
    South Yorkshire
    EnglandBritish133505110001
    WILKINSON, Stephen Philip
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    Amministratore
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    EnglandBritish35390660002
    BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    50433100001
    COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    43767230002

    AF REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 dic 2014
    Consegnato il 06 gen 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Lease
    Creato il 13 set 2006
    Consegnato il 18 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £17,331.25 including a sum equal to vat. The amount from time to time held in the deposit account for the credit of the tenant ("the deposit balance"). The amount from time to time standing to the credit of the deposit balance. All interest credited to the deposit balance from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Industrial Property Investment Fund
    Transazioni
    • 18 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 05 nov 2004
    Consegnato il 10 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from andrews fasteners limited and andfast trading company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ott 2004
    Consegnato il 28 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 16 nov 2001
    Consegnato il 21 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re andrews fasteners limited and numbered 6311907 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 16 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 04 lug 2001
    Consegnato il 12 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of offset
    Creato il 16 set 1992
    Consegnato il 05 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 24 gen 1991
    Consegnato il 31 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Govenor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 31 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 02 ott 1990
    Consegnato il 10 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of andrews fasteners limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 ott 1990
    Consegnato il 10 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 30 set 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £164,744 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. Fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ralin Holdings Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 apr 1984
    Consegnato il 04 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £16,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Ralin Holdings PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1984Registrazione di un'ipoteca

    AF REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2015Inizio dell'amministrazione
    10 ago 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Brooksbank
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Praticante
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    2
    DataTipo
    10 ago 2017Inizio della liquidazione
    18 set 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Brooksbank
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Praticante
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    Jeremy Michael Bennett
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Praticante
    Moorend House Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0