COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED

COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01532755
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Countryside House The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Neville Whitaker il 02 ago 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ian Scott il 04 feb 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Graham Stewart Cherry come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Ian Scott come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 apr 2016

    Stato del capitale al 21 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,350,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2015

    Stato del capitale al 24 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,350,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Philip Chatham come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Philip Chatham il 12 ago 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2014

    Stato del capitale al 25 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,350,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    1 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    SCOTT, Michael Ian
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    United KingdomBritish290228130001
    WHITAKER, Gary Neville
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    United KingdomBritish238965410002
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Segretario
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    British34860250001
    PEARCE, Michael Frank
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Segretario
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    British33032910001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    CHATHAM, Mark Philip
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    Amministratore
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    Essex
    EnglandBritish27018500002
    CHERRY, Alan Herbert
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish2026150001
    CHERRY, Graham Stewart
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Fridays
    Fox Road Mashbury
    CM1 4TJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish7228590002
    CHERRY, Richard Stephen
    Grove House
    Oxen End, Little Bardfield
    CM7 4PX Braintree
    Essex
    Amministratore
    Grove House
    Oxen End, Little Bardfield
    CM7 4PX Braintree
    Essex
    British68733260001
    DE BLABY, Richard Armand
    The Square House Smithbrook
    Lodsworth
    GU28 9DG Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    The Square House Smithbrook
    Lodsworth
    GU28 9DG Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish109841060001
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Amministratore
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish34860250001
    PEARCE, Michael Frank
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    EnglandBritish33032910001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    06 apr 2016
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00614864
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 18 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company to the chargee as security trustee (as therein defined) and/or any receiver on any account whatsoever pursuant to a facility agreement dated 26/4/91 and/or the debenture dated 30/4/91
    Brevi particolari
    All rights and interests of the company relating to the "deposit" standing to the credit of the account no. 019760 (for full details see form 395 tc ref: M142C).
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken- Und Wechsel-Bank Agas Security Trustee (As Therein Defined)
    Transazioni
    • 18 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 ago 1989
    Consegnato il 01 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC and/or sida properteis limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Northfields 22 st john road tunbridge wells kent title no. K 484471.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 20 set 1985
    Consegnato il 20 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 38 queen street deal kent f/h land & buildings lying to the south of copperfield road part of the neighbourhead centre north melbourne chelmsford essex t/n: K505488 and ex 244520 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 22 ago 1985
    Consegnato il 30 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 38 queen street, deal, kent t/n k 505488 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 22 ago 1985
    Consegnato il 30 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the south of copperfield road and forming part of the neighbourhood centre, north melbourne chelmsford essex t/n ex 244520 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 set 1981
    Consegnato il 12 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land comprised in title no. K505488.
    Persone aventi diritto
    • Majedie Investments LTD
    • Barlow Investments LTD
    Transazioni
    • 12 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1981
    Consegnato il 28 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,300,000
    Brevi particolari
    P/H property on the south side of copperfield road chelsmford essex together with the suppermarket. Forming part of T.n 218539.
    Persone aventi diritto
    • Barlow Investments Limited, Majedi Investments Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0