COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01532755 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Countryside House The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Essex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Neville Whitaker il 02 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Ian Scott il 04 feb 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Stewart Cherry come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Ian Scott come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Philip Chatham come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Philip Chatham il 12 ago 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARREN, Tracy Marina | Segretario | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||
| SCOTT, Michael Ian | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||
| WHITAKER, Gary Neville | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | 238965410002 | |||||
| HOYLES, Robin Patrick | Segretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||
| PEARCE, Michael Frank | Segretario | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Segretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
| CHATHAM, Mark Philip | Amministratore | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | England | British | 27018500002 | |||||
| CHERRY, Alan Herbert | Amministratore | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | 2026150001 | |||||
| CHERRY, Graham Stewart | Amministratore | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | England | British | 7228590002 | |||||
| CHERRY, Richard Stephen | Amministratore | Grove House Oxen End, Little Bardfield CM7 4PX Braintree Essex | British | 68733260001 | ||||||
| DE BLABY, Richard Armand | Amministratore | The Square House Smithbrook Lodsworth GU28 9DG Petworth West Sussex | United Kingdom | British | 109841060001 | |||||
| HOYLES, Robin Patrick | Amministratore | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | United Kingdom | British | 34860250001 | |||||
| PEARCE, Michael Frank | Amministratore | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | England | British | 33032910001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countryside Properties (Uk) Limited | 06 apr 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COUNTRYSIDE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Creato il 07 set 1992 Consegnato il 18 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company to the chargee as security trustee (as therein defined) and/or any receiver on any account whatsoever pursuant to a facility agreement dated 26/4/91 and/or the debenture dated 30/4/91 | |
Brevi particolari All rights and interests of the company relating to the "deposit" standing to the credit of the account no. 019760 (for full details see form 395 tc ref: M142C). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 ago 1989 Consegnato il 01 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC and/or sida properteis limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Northfields 22 st john road tunbridge wells kent title no. K 484471. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 20 set 1985 Consegnato il 20 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land k/a 38 queen street deal kent f/h land & buildings lying to the south of copperfield road part of the neighbourhead centre north melbourne chelmsford essex t/n: K505488 and ex 244520 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 22 ago 1985 Consegnato il 30 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land k/a 38 queen street, deal, kent t/n k 505488 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 22 ago 1985 Consegnato il 30 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and buildings lying to the south of copperfield road and forming part of the neighbourhood centre, north melbourne chelmsford essex t/n ex 244520 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 set 1981 Consegnato il 12 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H land comprised in title no. K505488. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 apr 1981 Consegnato il 28 apr 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,300,000 | |
Brevi particolari P/H property on the south side of copperfield road chelsmford essex together with the suppermarket. Forming part of T.n 218539. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0