FEDEX UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFEDEX UK LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01541168
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di FEDEX UK LIMITED?

    • Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova FEDEX UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Express House
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FEDEX UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANC LIMITED26 gen 199626 gen 1996
    A.N.C. LIMITED23 gen 198123 gen 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di FEDEX UK LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mag 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il29 feb 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per FEDEX UK LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 mag 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per FEDEX UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 feb 2025

    7 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 feb 2024

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Bilancio redatto al 31 mag 2022

    45 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Edward Robert Clarke come amministratore in data 01 mar 2023

    1 pagineTM01

    Stato del capitale al 11 ott 2022

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Pankaj Verghese Alexander come amministratore in data 09 giu 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mag 2021

    43 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Pankaj Verghese Alexander il 09 mar 2022

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2020

    43 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Roel Jos Coleta Staes come amministratore in data 19 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helena Jansson come amministratore in data 19 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Edmund Hawkins come segretario in data 19 mar 2021

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lawrence Trevor Hoyle come amministratore in data 19 mar 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Steve Wilkins come amministratore in data 19 mar 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Edmund Hawkins come amministratore in data 19 mar 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Pankaj Verghese Alexander come amministratore in data 19 mar 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Edward Robert Clarke come amministratore in data 19 mar 2021

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FEDEX UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, James Alexander
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor270834780001
    PETO, Robert James
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Fedex Express
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Fedex Express
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusiness Executive196399770001
    WILKINS, Steve
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United Kingdom
    EnglandBritishHr Executive268772910001
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    British87327210001
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Segretario
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishFinance Director101387860002
    PARROTT, Stephen John
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    Segretario
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    BritishBusiness Executive48941480002
    RONALD, Paul
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    Segretario
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    British71473700001
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Segretario
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    ADAMS, Michael Joseph
    18 Dorchester Road
    B91 1LW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    18 Dorchester Road
    B91 1LW Solihull
    West Midlands
    BritishDirector Of International Serv31873110001
    ALEXANDER, Pankaj Verghese
    Vliegveld
    Steenokkerzeel 1820
    117b
    Belgium
    Amministratore
    Vliegveld
    Steenokkerzeel 1820
    117b
    Belgium
    BelgiumBelgianChartered Accountant197360150002
    ALLEN, Mark Russell
    St.Goedeleplein 14
    Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    1000
    Belgium
    Amministratore
    St.Goedeleplein 14
    Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    1000
    Belgium
    BelgiumAmericanBusiness Executive77781820002
    CALLAGHAN, Andrew Michael
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    Amministratore
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    BritishChief Executive76165950001
    CLARKE, Edward Robert
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    United KingdomBritishBusiness Executive281051640001
    CLARKE, Justin Neil
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    EnglandBritishSolicitor184467260002
    COWAN, Geoffrey Alan
    26 Satinwood Close
    Gerrards Park
    WN4 9NL Ashton In Makerfield
    Lancashire
    Amministratore
    26 Satinwood Close
    Gerrards Park
    WN4 9NL Ashton In Makerfield
    Lancashire
    BritishOperations Director77265020001
    CRANMER, Charles David
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishFinance Director60508750002
    DAVIDIAN, Martin Lee
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishSales Director90928040002
    DEAN, Wendy Jane
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishDirector90928110002
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    BritishFinance Director87327210001
    ELLIOTT, Robert William
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    Amministratore
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    AmericanBusiness Executive77782020004
    GITTINS, Jonathan Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishCeo75431680002
    GREEN, Anthony Eric
    50 Mount Pleasant
    ST5 1DP Newcastle Upon Tyne
    Staffordshire
    Amministratore
    50 Mount Pleasant
    ST5 1DP Newcastle Upon Tyne
    Staffordshire
    United KingdomBritishI T Director101179930001
    HAMILL, John
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishFranchise Director90927770002
    HAWKINS, James Edmund
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    Amministratore
    Holly Lane
    CV9 2RY Atherstone
    Express House
    EnglandBritishFinance Director101387860002
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance Director101387860002
    HAY, James Brian
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    BritishChartered Accountant11163140001
    HENDERSON, John Iain
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    Amministratore
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    BritishChartered Accountant38376070001
    HOLT, Michael John
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishOperations Director121123210001
    HOYLE, Lawrence Trevor
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Parkhouse East Industrial Estate
    Staffordshire
    Amministratore
    ST5 7RB Newcastle Under Lyme
    Parkhouse East Industrial Estate
    Staffordshire
    EnglandBritishGroup Operations Director130938230003
    JACKSON, Edward Thomas
    Little West End Wistaston Green Road
    CW2 8SA Crewe
    Amministratore
    Little West End Wistaston Green Road
    CW2 8SA Crewe
    BritishPersonnel Director37861110003
    JANSSON, Helena
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc
    Belgium
    Amministratore
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc
    Belgium
    BelgiumSwedishBusiness Executive184103240001
    JONES, Helen Louise
    Anc Group Head Office, Parkhouse Road East
    Parkhouse Industrial Estate East
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office, Parkhouse Road East
    Parkhouse Industrial Estate East
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishDivisional Managing Director114989800001
    KENNEDY, Stephen
    Gas House Cottage Watling Street
    Weston Under Lizard
    TF11 8LG Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Gas House Cottage Watling Street
    Weston Under Lizard
    TF11 8LG Shifnal
    Shropshire
    BritishSales & Marketing Director60508570003
    KOVAL, Kenneth Francis
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    AmericanFinance Director118262180001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Amministratore
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    BritishChief Executive20509810002

    Chi sono le persone con controllo significativo di FEDEX UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle-Under-Lyme
    .
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle-Under-Lyme
    .
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleLaws Of England
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1623790
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FEDEX UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 02 feb 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due up to a maximum of £8,000,000 from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited as 'Security Trustee'
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and fixed and floating security document
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage over leasehold title
    Creato il 12 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at unit 6 marston gate development site station road brogborough milton keynes bedfordshire comprised in a lease dated 13/10/99 between prologis UK iii sarl and the company together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery therein or thereon and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First fixed charge in respect of trade marks
    Creato il 12 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed chage all the company's right title and interest in and to all the trade marks owned by the company whether or not registered and hether or not registerable.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage over freehold title
    Creato il 12 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or anc holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle -under-lyme t/no;-SF245317 all buildings and fixtures fittings fixed plant and machinery therein and thereon and/the proceeds of sale thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 12 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture, the other finance documents or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 08 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Montagu Equity Limitedas Agent for the Holders from Time to Time of the Stock
    Transazioni
    • 08 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 10 lug 1992
    Consegnato il 16 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of lease dted 27/4/90 and/or this charge
    Brevi particolari
    The sum of £8,850.00 deposited by the nottinghamshire county council with the cooperative bank PLC of 15 friar lane nottingham.
    Persone aventi diritto
    • The Nottinghamshire County Council
    Transazioni
    • 16 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 lug 1988
    Acquisito il 01 gen 1993
    Consegnato il 15 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £36,000,000
    Brevi particolari
    The business of anc holdings limited including assets except for those excluded in the agreement.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 15 gen 1993Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 07 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 08 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or stuntbrand limited and/or all or any companies named therein to standard chartered bank
    Brevi particolari
    (Refer to form M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank (Please See Form M395 & Schedule for Full Details Ref M317)
    Transazioni
    • 08 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set-off
    Creato il 19 mag 1986
    Consegnato il 22 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    All sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    All moneys debenture
    Creato il 15 ago 1985
    Consegnato il 04 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first specific equitable charge all estates or interests in any f/h & l/h property now and at any time during the continuance of the debenture belonging to or charged to the company and/or the proceeds of sale thereof. (See doc M13 for details).
    Persone aventi diritto
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transazioni
    • 04 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 11 nov 1983
    Consegnato il 24 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee and debenture
    Creato il 21 lug 1982
    Consegnato il 28 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company & to the chargee on any account whatsoever. & and/or all or any of the office companies named therein
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (and made fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 23 giu 1981
    Consegnato il 29 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold, unit 15, scott-lidgett estate, scott-lidgett road, longport, stoke on trent, staffs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 23 giu 1981
    Consegnato il 29 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1981Registrazione di un'ipoteca

    FEDEX UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 feb 2024Inizio della liquidazione
    22 feb 2024Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0