MOCOR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOCOR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01543832
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MOCOR LIMITED?

    • (5143) /

    Dove si trova MOCOR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower 12 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOCOR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROCOM LIMITED14 set 200614 set 2006
    ROCOM GROUP LIMITED22 mar 199622 mar 1996
    ROCOM LIMITED20 nov 198620 nov 1986
    ROCOM SYSTEMS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    DEWFORD LIMITED06 feb 198106 feb 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOCOR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MOCOR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Indirizzo della sede legale modificato da Hollins Mount Hollins Lane Bury BL9 8DG a Tower 12 18/22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ in data 10 gen 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 giu 2015

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 giu 2014

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 giu 2013

    13 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Carlton House 16-18 Albert Square Manchester M2 5PE* in data 06 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 giu 2012

    11 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 30 giu 2011

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Nexus Solicitors Carlton Hoouse 16-18 Albert Square Manchester M2 5PE United Kingdom* in data 13 mag 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 ago 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2011

    Stato del capitale al 09 mar 2011

    • Capitale: GBP 180,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Rocom Limited Agecroft Road Pendlebury Manchester M27 8SB United Kingdom* in data 11 ott 2010

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2010 al 31 ago 2010

    1 pagineAA01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed rocom LIMITED\certificate issued on 02/10/10
    4 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    02 ott 2010

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    8 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 22 set 2010

    RES15

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    19 pagineAA

    Nomina di Mr Saul Loggenberg come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Gee come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di MOCOR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOGGENBERG, Saul
    18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Tower 12
    Amministratore
    18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Tower 12
    South AfricaBritish154392440001
    GEE, Christopher Philip
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    Segretario
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    British137663760001
    HAYWARD, John William
    25 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HE London
    Segretario
    25 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HE London
    British111473800001
    HODGSON, Angela Michele
    328 Wakefield Road
    HD5 8DQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    328 Wakefield Road
    HD5 8DQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British97385330001
    LINES, Doreen
    Stone Court 37 Spofforth Hill
    LS22 6SF Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    Stone Court 37 Spofforth Hill
    LS22 6SF Wetherby
    West Yorkshire
    British10299250001
    PHILLIPS, Elaine Lesley
    4 East Parade
    YO31 7YJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    4 East Parade
    YO31 7YJ York
    North Yorkshire
    British39032080002
    WEBB, Forbes Waddington
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    Segretario
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    British84060000001
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    BUCKLEY, James Peter
    Love Lane House
    Love Lane South Cave
    HU15 2AA Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Love Lane House
    Love Lane South Cave
    HU15 2AA Brough
    East Yorkshire
    British81874780001
    CAMFIELD, Jain Anne
    Pikes Head Lodge Cattle Lane
    Aberford
    LS25 3BH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pikes Head Lodge Cattle Lane
    Aberford
    LS25 3BH Leeds
    West Yorkshire
    British54901130001
    CARTER, Richard Michael
    Nine Acres, 78 Manchester Road
    SK9 2JY Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Nine Acres, 78 Manchester Road
    SK9 2JY Wilmslow
    Cheshire
    British6602780002
    CHARNOCK, Christopher Gerard
    6 Coverdale Close
    Whittle Hall
    WA5 3DH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    6 Coverdale Close
    Whittle Hall
    WA5 3DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish50246180001
    CUNNINGHAM, John
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    EnglandEnglish69469980002
    GIBBARD, Peter William
    7 St Johns Crescent
    YO3 7QP York
    Amministratore
    7 St Johns Crescent
    YO3 7QP York
    British10401960003
    GILLINGS, Paula
    83 Grove Lane
    SK8 7LZ Cheadle Hulme
    Stockport
    Amministratore
    83 Grove Lane
    SK8 7LZ Cheadle Hulme
    Stockport
    EnglandBritish106635250002
    GRANT, Anthony Ernest
    63 Old Park Road
    LS8 1JB Leeds
    Amministratore
    63 Old Park Road
    LS8 1JB Leeds
    United KingdomBritish9952930001
    HAMBLY, Philip
    7 Crofters Green
    Killinghall
    HG3 2GY Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 Crofters Green
    Killinghall
    HG3 2GY Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish102768960001
    HARRISON, Stephen John
    2 Templar Gardens
    LS22 7TG Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Templar Gardens
    LS22 7TG Wetherby
    West Yorkshire
    British10375510001
    KEAN, Scott Charles
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British80444700003
    KEITH, Alan Michael
    108 Churchfields
    Shoeburyness
    SS3 8TN Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    108 Churchfields
    Shoeburyness
    SS3 8TN Southend On Sea
    Essex
    British36279010002
    LINES, Doreen
    Stone Court 37 Spofforth Hill
    LS22 6SF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stone Court 37 Spofforth Hill
    LS22 6SF Wetherby
    West Yorkshire
    British10299250001
    LISTER, Alex
    3 Lascelles Grove
    HG2 0LB Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Lascelles Grove
    HG2 0LB Harrogate
    North Yorkshire
    British97385250002
    LOVELL, David John
    Furrowfield
    St Johns Road Scotton
    HG5 9HT Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Furrowfield
    St Johns Road Scotton
    HG5 9HT Knaresborough
    North Yorkshire
    British57944900001
    MASSEY, Raymond John
    329 Benfleet Road
    SS7 1PW South Benfleet
    Essex
    Amministratore
    329 Benfleet Road
    SS7 1PW South Benfleet
    Essex
    United KingdomBritish44018860001
    NICOL, Richard Mcpike
    White Smithy Barn
    Paradise Lane
    LS24 9NJ Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    White Smithy Barn
    Paradise Lane
    LS24 9NJ Tadcaster
    North Yorkshire
    British74213720001
    NIMAN, Julian Howard
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Agecroft Road
    Pendlebury
    M27 8SB Manchester
    Rocom Limited
    United Kingdom
    United KingdomEnglish6602760004
    NORMAN, Stephen Malcolm
    Flat 3
    27 Rutland Drive
    HG1 2NS Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Flat 3
    27 Rutland Drive
    HG1 2NS Harrogate
    North Yorkshire
    British116497770001
    OLD, Robert Lee
    Kiln Hill Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiln Hill Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish10299260001
    OLD, Thelma Elizabeth
    Kiln Hill Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiln Hill Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish198820170001
    PHILLIPS, Elaine Lesley
    4 East Parade
    YO31 7YJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 East Parade
    YO31 7YJ York
    North Yorkshire
    British39032080002
    STRAIN, John David
    14 Thorp Arch Mill
    Thorp Arch
    LS23 7DZ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Thorp Arch Mill
    Thorp Arch
    LS23 7DZ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish54822630001
    TUNESI, Gregory James Edmund Ernest
    60 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    60 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish38920830002
    TUPMAN, Timothy Alexander
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67184090006
    WEBB, Forbes Waddington
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    Amministratore
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    British84060000001

    MOCOR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mar 2009
    Consegnato il 02 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creato il 24 mar 2009
    Consegnato il 02 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 mar 2009
    Consegnato il 31 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • At Communication Group PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2008
    Consegnato il 05 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The warehouse and communications building, separate office building and gatehouse thorpe arch trading estate wetherby.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 2006
    Consegnato il 23 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as thorp arch trading estate wetherby west yorkshire t/n's WYK465257 WYK370239 and WYK754664.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ago 2006
    Consegnato il 23 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 29 feb 2000
    Consegnato il 18 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the service provider agreement dated 29 february 2000
    Brevi particolari
    First fixed charge all claims in intellectual property and goodwill in the subscriber base. All debts and other debts standing to the credit of rocom group limited in the account name of "rocom group/vodafone designated account" withlloyds tsb bank PLC or any other bank. Floating charge to the remainder of the subscriber base.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 18 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 1997
    Consegnato il 18 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,091,741 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land lying to the north of avenue c east thorp arch wetherby west yorkshire t/n WYK370529.
    Persone aventi diritto
    • N.P.I. Trustee Services Limitedrobert Lee Old, Thelma Elizabeth Old and Doreenlines (As Trustees of the Romcom Limited Shareholders Pension Scheme)
    Transazioni
    • 18 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 lug 1986
    Consegnato il 28 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MOCOR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 giu 2011Inizio della liquidazione
    15 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Maloney
    Leonard Curtis Hollins Mount
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praticante
    Leonard Curtis Hollins Mount
    Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    John Malcolm Titley
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praticante
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0