MISYS KBS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMISYS KBS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01545543
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MISYS KBS LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MISYS KBS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MISYS KBS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINDLE BANKING SYSTEMS LIMITED17 ott 199517 ott 1995
    ACT BANKING SYSTEMS (U.K.) LIMITED14 apr 199414 apr 1994
    ACT KINDLE (U.K.) LIMITED04 giu 199204 giu 1992
    KINDLE LIMITED29 nov 198529 nov 1985
    TRIPLE A SYSTEMS LIMITED25 apr 198325 apr 1983
    M.A. SOFTWARE LIMITED17 mar 198217 mar 1982
    M.A. SYSTEMS (LONDON) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    PEACEPAR LIMITED13 feb 198113 feb 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MISYS KBS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per MISYS KBS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 mag 2016

    28 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 mag 2015

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 23 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Paul Woodward come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Patel come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Van Harken come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Mary Collins come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2014

    Stato del capitale al 06 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    12 pagineAA

    Nomina di Mrs Elizabeth Mary Collins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Hawkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Sanjay Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Joanna Marageret Hawkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bijal Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Edward Timothy Homer il 20 mag 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 23 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Bijal Mahendra Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MISYS KBS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    Segretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    146638700001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Segretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    170449080001
    CLANCY, Conall Patrick
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish37703500001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COLWELL, John
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    Amministratore
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    British98195430003
    DERRER, Andrew Jan
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    Amministratore
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    EnglandBritish121601200001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Amministratore
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    KILDUFF, Martin Anthony
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish32778090001
    MEANY, Patrick Declan
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Amministratore
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Irish82121570001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NOCTOR, Desmond James
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Irish32778100001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    STOKES, Mark
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Amministratore
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Irish82121580001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    SUSSENS, John Gilbert
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1442450001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04217573
    158141250001

    MISYS KBS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 28 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's book debts and other receivables present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 28 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 nov 1986
    Consegnato il 18 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of collateral debenture
    Creato il 26 mag 1986
    Consegnato il 16 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from kindle group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    By way of floating security all the company's undertaking and assets present and future including uncalled capital for the time being & goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Industrial Credit Corporation PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of chattel mortgage
    Creato il 26 mag 1986
    Consegnato il 16 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the property & assets listed in doc M29. (See doc M29 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 19 giu 1985
    Consegnato il 03 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the M. A. bereau services LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoerver both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill.
    Persone aventi diritto
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 19 giu 1985
    Consegnato il 03 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the M. A. systems LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital fot the time being and goodwill.
    Persone aventi diritto
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MISYS KBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ott 2017Data di scioglimento
    27 mag 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0