SKY SIGNS BALLOONS LTD

SKY SIGNS BALLOONS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSKY SIGNS BALLOONS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01547203
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    38 Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    Lincolnshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICARUS LIMITED24 feb 198124 feb 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Broadgate House Church Street Deeping St James Peterborough. PE6 8HD a 38 Beech Avenue Bourne Lincolnshire PE10 9RR in data 31 dic 2018

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Societe Financiere Pour L'etranger (S.F.E.) Nv come persona con controllo significativo il 01 nov 2018

    2 paginePSC05

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 gen 2016

    Stato del capitale al 14 gen 2016

    • Capitale: GBP 120
    SH01

    Nomina di Mrs Katherine Mary Michelson come segretario in data 30 set 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Darren Paul Michelson come amministratore in data 30 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Carol Ann Heath come segretario in data 30 set 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John David Joseph Heath come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2015

    Stato del capitale al 16 gen 2015

    • Capitale: GBP 120
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 120
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MICHELSON, Katherine Mary
    Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    38
    Lincolnshire
    England
    Segretario
    Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    38
    Lincolnshire
    England
    201741290001
    MICHELSON, Darren Paul
    Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    38
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    38
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritish90999090001
    HEATH, Carol Ann
    The White House Bradley Brook Lane
    SY14 8DH Malpas
    Cheshire
    Segretario
    The White House Bradley Brook Lane
    SY14 8DH Malpas
    Cheshire
    British1806440002
    LAVENDER, Robert
    Fairfax House Riverside
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    Segretario
    Fairfax House Riverside
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    British3249930002
    LAVENDER, Vivienne Jane
    Fairfax House
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    Lincolnshire
    Segretario
    Fairfax House
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    Lincolnshire
    British136620080001
    MICHELSON, Darren Paul
    38 Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    Lincolnshire
    Segretario
    38 Beech Avenue
    PE10 9RR Bourne
    Lincolnshire
    British90999090001
    BERRINGTON, Penelope Irene
    High Oaks11 Brownfield Way
    Blackore End
    AL4 8LL Wheathampstead
    Amministratore
    High Oaks11 Brownfield Way
    Blackore End
    AL4 8LL Wheathampstead
    British88711740002
    BONSER, Stephen Peter
    The Birches Birch Grove
    Chilbolton
    SO20 6BH Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    The Birches Birch Grove
    Chilbolton
    SO20 6BH Stockbridge
    Hampshire
    British24601320001
    HEATH, John David Joseph
    The White House
    Bradley Brook Lane
    SY14 8DH Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    The White House
    Bradley Brook Lane
    SY14 8DH Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish1806450002
    LAVENDER, Robert
    Fairfax House Riverside
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    Amministratore
    Fairfax House Riverside
    Deeping Gate
    PE6 9AJ Peterborough
    United KingdomBritish3249930002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SKY SIGNS BALLOONS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Belbal Nv
    J Cardijnstraat
    9420 Erpe-Mere
    18
    Belgium
    06 apr 2016
    J Cardijnstraat
    9420 Erpe-Mere
    18
    Belgium
    No
    Forma giuridicaPartnership
    Autorità legaleBelgium
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SKY SIGNS BALLOONS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 05 ott 2005
    Consegnato il 15 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings lying to the north church street deeping st james lincolnshire and land to the rear of 76 church street deeping st james lincolnshire t/n LL108923 & LL226663.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 14 feb 2002
    Consegnato il 06 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the property k/a 72 church street, deeping st j ames, peterborough, PE6 8HD.
    Persone aventi diritto
    • Financiere De L'alzette Sa
    Transazioni
    • 06 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 24 lug 2001
    Consegnato il 24 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery or any part thereof belbal silkscreen printing machine bsplss serial number BSPLSS1200100035.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 24 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 ott 2000
    Consegnato il 19 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Belcan balloon printing machine BSPL22 12/spk-12/cpk-12 s/no. 0040029.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new poly -skrener 500 silk screen balloon imprinyting machine serial no 3-83-94.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 gen 1998
    Consegnato il 14 gen 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 15 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at 76 church street deeping st james together with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery goodwill and the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich and Peterborough Building Society
    Transazioni
    • 15 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 25 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof schedule new poly skrener 2000 2 colour automatic balloon screen printing machine serial number 2-99-95.
    Persone aventi diritto
    • Forwrd Trust Limited
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1994
    Consegnato il 02 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H warehouse premises and land to the rear of 72 church street deeping st james peterborough. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 giu 1984
    Consegnato il 05 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & all other debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0