PLANNING CONSULTANCY LIMITED

PLANNING CONSULTANCY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPLANNING CONSULTANCY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01549883
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Amen Corner
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Berkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMPWARD LIMITED11 mar 198111 mar 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagine4.71

    legacy

    3 pagineMG02

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 giu 2010

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2010

    Stato del capitale al 27 apr 2010

    • Capitale: GBP 196,166
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas Wilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Dara Singh Gil come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2009

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di James Ormrod come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Thomas Clark Perkins come segretario

    1 pagineAP03

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di PLANNING CONSULTANCY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PERKINS, Thomas Clark
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    147606090001
    GILL, Dara Singh
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish149165080001
    LEWTHWAITE, Mark
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    Amministratore
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    EnglandBritish134517020001
    GUTKIN, John Solomon
    2 Merrywood Park
    GU15 1JR Camberley
    Surrey
    Segretario
    2 Merrywood Park
    GU15 1JR Camberley
    Surrey
    Irish25749200001
    LA CALAMITA, John Michael
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    Segretario
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    British51659910001
    ORMROD, James
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Segretario
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Other130250210001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    PRICHARD, Teresa Joan
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Segretario
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    British42862810001
    ROY, David Maitland
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    Segretario
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    British46026850002
    EDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    69779900001
    ARONAHO, Kauko
    26 Glenbourne Park Dr
    L6C 1H4 Markham
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    26 Glenbourne Park Dr
    L6C 1H4 Markham
    Ontario
    Canada
    Canadian45453490001
    BURY, Lindsay Claude Neils
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    Amministratore
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish67103750001
    CRONIN, Thomas Alfred
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Amministratore
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Canadian56798460001
    GAFFNEY, Thomas Anthony
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Amministratore
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Canadian/Irish54394580001
    GILL, Stephen
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    British56193720001
    GUTKIN, John Solomon
    2 Merrywood Park
    GU15 1JR Camberley
    Surrey
    Amministratore
    2 Merrywood Park
    GU15 1JR Camberley
    Surrey
    Irish25749200001
    LAMBTON, Mark Norman
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    Amministratore
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    United KingdomBritish162510100001
    LAY, Graham Richard David
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    Amministratore
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    EnglandBritish33300160001
    LINTON, William Warwick
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    Amministratore
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    CanadaCanadian115579350001
    MADDEN, James
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    Amministratore
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    American65642080001
    MCLAREN, Donald Ian
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Amministratore
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Canadian62159130001
    MOSES, Dhyanchand
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    Amministratore
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    American64548230001
    PAYNE, Stuart Michael
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish17465450001
    PRICHARD, Teresa Joan
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Amministratore
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    British42862810001
    ROWLEDGE, Peter Eric
    The Old Forge
    Stratford-St-Mary
    CO7 6JS Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Old Forge
    Stratford-St-Mary
    CO7 6JS Colchester
    Essex
    United KingdomBritish6479710001
    STOUT, John William Priestner
    16 Queen Annes Gate
    Caversham
    RG4 5DU Reading
    Amministratore
    16 Queen Annes Gate
    Caversham
    RG4 5DU Reading
    EnglandBritish62052130001
    SUMMERS, Graham Michael
    77 Barrowgate Road
    W4 4QS Chiswick
    London
    Amministratore
    77 Barrowgate Road
    W4 4QS Chiswick
    London
    EnglandBritish156327340001
    WILSON, Nicholas Anthony
    Ardwell Close
    RG45 6AG Crowthorne
    14 Wellington Mansions
    Berkshire
    Amministratore
    Ardwell Close
    RG45 6AG Crowthorne
    14 Wellington Mansions
    Berkshire
    United KingdomBritish137369560001
    EDS NOMINEES LIMITED
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    69780130001

    PLANNING CONSULTANCY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of ground floor of 25 kings road reading berkshire t/no BK235582.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1991
    Consegnato il 21 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit C7 hortonwood 10, telford, shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 08 nov 1991
    Consegnato il 18 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 3RD june 1981
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company along with book and other debts see form 395 for full details ref M435C.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 22 nov 1990
    Consegnato il 28 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the stock financing agreement
    Brevi particolari
    Floating charge upon the products under the dealer agreement stock in trade (for full details see form 395 ref M41).
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 28 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Credit agreement
    Creato il 04 set 1990
    Consegnato il 11 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £107,810.20 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the credit application
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances (for full details refer to doc 395 ref M82C).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 11 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1988
    Consegnato il 26 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit C7, hortonwood 10, telford, shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1988
    Consegnato il 26 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1, heathrow summit centre, skyport drive, harmondsworth, west drayton, london borough of hillingdon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1988
    Consegnato il 26 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Enterprise house 8-28 woodfield place london borough of city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1988
    Consegnato il 26 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St.giles house, 25 kings road, reading, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 giu 1981
    Consegnato il 09 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill & bookdebts together with all fixtures plant & machinery (see doc M7).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PLANNING CONSULTANCY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mag 2011Data di scioglimento
    30 giu 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0