ARMSTRONG STEEL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ARMSTRONG STEEL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01560805 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARMSTRONG STEEL LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| G.F.J. ARMSTRONG LIMITED | 12 mag 1981 | 12 mag 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di George Clinton Jones come amministratore in data 16 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Whiting come amministratore in data 14 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 20 dic 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr David Gross come amministratore in data 14 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kakha Avaliani come amministratore in data 14 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ciara Milne come segretario in data 01 ott 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ciara Milne come amministratore in data 16 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 7 pagine | RP04CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS, David | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | England | American | 253044410001 | |||||
| WHITING, Peter | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | England | British | 290517860001 | |||||
| DEVONPORT, Karen | Segretario | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | British | 108483890002 | ||||||
| JOYCE, Martin Joseph | Segretario | 2 Spa Mews Boston Spa LS23 6TR Leeds West Yorkshire | British | 7474650002 | ||||||
| MARJORIBANKS, Richard John Bradley | Segretario | Road Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm West Yorkshire England | 178398740001 | |||||||
| MIDDIS, Kevin John | Segretario | Silverdale Old Forge Gardens DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | British | 81620510001 | ||||||
| MILNE, Ciara | Segretario | Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm Road West Yorkshire England | 212824070001 | |||||||
| SPENCER, Joanne Louise | Segretario | 22 Lidgett Way Royston S71 4FD Barnsley South Yorkshire | British | 83985870001 | ||||||
| WHITE, John | Segretario | Fairview Lockwood Road Kingsley Holt ST10 2BE Stoke On Trent Staffordshire | British | 58650740001 | ||||||
| ARMSTRONG, Gregory Francis John | Amministratore | 5 Barnetts Grove DY10 3HG Kidderminster Worcestershire | British | 9444610001 | ||||||
| AVALIANI, Kakha | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | England | British | 152448300001 | |||||
| BATTERSBY, Miles | Amministratore | 11 Calverhall Way WN4 9LB Ashton In Makerfield Lancashire | British | 79773380001 | ||||||
| BENBOW, Martin | Amministratore | 59 Park Road Hagley DY9 0QQ Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 109354670001 | |||||
| BEVERIDGE, Ian Craik | Amministratore | Swan Bank 12 Fells Orchard Oldbury WV16 5DZ Bridgnorth Salop | British | 69915590001 | ||||||
| BOWDEN, Peter John | Amministratore | Landsdown House 25 Gainsborough Mews DY11 6PZ Kidderminster Worcestershire | British | 80298890001 | ||||||
| DEVONPORT, Karen | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | United Kingdom | British | 108483890002 | |||||
| EATON, Robert | Amministratore | 34 Unity Park Dykehead ML7 4AN Shotts Lanarkshire | British | 56524960002 | ||||||
| FORSTER, Philip | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | England | British | 126920290001 | |||||
| FOSBROOK, Gary | Amministratore | 53 Oakhurst Drive Wistaston CW2 6UE Crewe Cheshire | England | British | 76689640001 | |||||
| HEWITT, Colin Graham | Amministratore | 7 Newcastle Bank DH3 1PT Birtley County Durham | United Kingdom | British | 155493040001 | |||||
| HUGHES, Richard Michael | Amministratore | 7 Tenbury Road Cleobury Mortimer DY14 8RB Kidderminster Worcestershire | British | 9447650001 | ||||||
| HURST, Philip John | Amministratore | The Court House 12 Draycott Road Upper Tean ST10 4JF Stoke On Trent Staffordshire | British | 9447640003 | ||||||
| JONES, George Clinton | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | United Kingdom | British | 70121220002 | |||||
| JOYCE, Martin Joseph | Amministratore | 2 Meynell Lane Meynell Road Colton LS15 9BZ Leeds West Yorkshire | England | British | 7474650008 | |||||
| MACDONALD, Alexander Scott | Amministratore | 2 St Helens Grove Sandal WF2 6RR Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 3480700001 | |||||
| MIDDIS, Kevin John | Amministratore | Silverdale Old Forge Gardens DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | England | British | 81620510001 | |||||
| MILNE, Ciara | Amministratore | Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm Road West Yorkshire England | United Kingdom | British | 209116720001 | |||||
| NOCK, Michael Andrew | Amministratore | 3 Malvern View Clows Top DY14 9JE Kidderminster Worcestershire | England | British | 121470910001 | |||||
| PARK, Peter George | Amministratore | Flat 4 120 Drury Lane WC2B 5SU London | United Kingdom | British | 69867220002 | |||||
| SALTER, Barrie Clive | Amministratore | Valley Farm Road Leeds LS10 1SD West Yorkshire | United Kingdom | British | 136281840001 | |||||
| SKELTON, Nichola | Amministratore | Road Stourton LS10 1SD Leeds Valley Farm West Yorkshire England | United Kingdom | British | 161424200001 | |||||
| SWAIN, David Glenville | Amministratore | 7 Eleanor View Westlands ST5 3SD Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 79553680001 | ||||||
| TAINTON, John Samuel | Amministratore | Bramblings Frenchlands Lane WR2 6QU Lower Broadheath Worcestershire | British | 9305720001 | ||||||
| TAYLOR, Paul | Amministratore | 32 Sutherland Drive Westlands ST5 3EN Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 50931220001 | ||||||
| TIPLADY, John Eason | Amministratore | 7 Osborne Drive Todwick S26 1HW Sheffield South Yorkshire | British | 3480680001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ARMSTRONG STEEL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloeckner Metals Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Valley Farm Road LS10 1SD Leeds | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Asd Limited | 06 apr 2016 | Valley Farm Road LS10 1SD Leeds | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ARMSTRONG STEEL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 17 feb 2006 Consegnato il 18 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a berry hill road, stoke-on-trent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 feb 2006 Consegnato il 18 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a drum road, drum industrial estate, chester-le-street. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 08 dic 2005 Consegnato il 10 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 1 march 2006 and | Creato il 07 dic 2005 Consegnato il 09 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 14 glasgow road bathgate t/no wln 5297. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Group debenture | Creato il 16 mar 2005 Consegnato il 19 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as security agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 29 june 2004 and | Creato il 10 mar 2004 Consegnato il 10 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Subjects at millburn road bathgate t/n WLN5297. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 nov 2002 Consegnato il 12 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or asd PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the west sde of drum road birtley chester-le-street durham t/n DU185305. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 nov 2002 Consegnato il 12 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or asd PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land to the north of berry hill road fenton stoke-on-trent t/n SF252287. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 14 ago 2002 Consegnato il 20 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 nov 1988 Consegnato il 06 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 gen 1982 Consegnato il 12 gen 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over goodwill & book debts tog with all fixtures plant & machinery (see doc M8). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0