ELISABETH THE CHEF LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ELISABETH THE CHEF LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01561100 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ELISABETH THE CHEF LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 50 Pontefract Lane LS9 8HY Leeds England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SENOBLE UK LIMITED | 01 lug 2011 | 01 lug 2011 |
| ELISABETH THE CHEF LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| CAPECLASS LIMITED | 13 mag 1981 | 13 mag 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 23 apr 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 07 mag 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 apr 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 30 apr 2025 | 16 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Elisabeth the Chef Holdings Limited come persona con controllo significativo il 30 ott 2025 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2024 | 17 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2023 | 22 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2022 | 22 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Joseph Anthony Wood come amministratore in data 28 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2021 | 23 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2020 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 apr 2019 | 24 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate Leamington Spa Warwickshire CV31 1NB a 50 Pontefract Lane Leeds LS9 8HY in data 12 ago 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 30 apr 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 27 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 29 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Notifica di Elisabeth the Chef Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 nov 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Marc Claude Andre Senoble come persona con controllo significativo il 01 nov 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||
Nomina di Mr Charles Joseph Wood come amministratore in data 01 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Joseph Anthony Wood come amministratore in data 01 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD, Charles Joseph | Amministratore | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | England | British | 73248470002 | |||||
| CHALMERS, Julie Anne | Segretario | 6 The Hamlet Leek Wootton CV35 7QW Warwick Warwickshire | British | 27576500002 | ||||||
| MOORHOUSE, Robert Thomas | Segretario | 1 Glebeland Close Thrussington LE7 4TT Leicester Leicestershire | British | 61955460001 | ||||||
| AVRAIN, Guillaume Jean Joel Daniel | Amministratore | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Senoble Uk Warwickshire United Kingdom | England | French | 288149810001 | |||||
| BALMER, Stephen David | Amministratore | 8 Charnwood Way Lillington CV32 7BU Leamington Spa Warwickshire | British | 44592470001 | ||||||
| BECARD, Arnaud, Mister | Amministratore | 30 Rue Des Jacquins 89100 Jouy Senso Yonne France | France | French | 207057420001 | |||||
| BESSET, Olivier Francois Yves | Amministratore | Rue Des Jacquins C/O Senoble Holding, 30 Rue Des Jacquins 89150 Jouy C/O Senoble Holding 30 France | France | French | 176990840001 | |||||
| BRILEY, Colin John | Amministratore | 410 Quinton Road West Quinton B32 1QG Birmingham | British | 44744190001 | ||||||
| CHALMERS, Julie Anne | Amministratore | 6 The Hamlet Leek Wootton CV35 7QW Warwick Warwickshire | British | 27576500002 | ||||||
| DANIELL, Christopher | Amministratore | Ashley Farm Staunton-On-Arrow HR6 9LN Leominster Herefordshire | British | 27576490001 | ||||||
| DAVE, Lewis, Mister | Amministratore | 4 Berrington Road Syndenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Senoble Uk Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | English | 207113220001 | |||||
| EASTHAM, Stephen Ralph | Amministratore | 9 Pitters Piece Long Crendon HP18 9PP Aylesbury Buckinghamshire | British | 78805340001 | ||||||
| GIBSON, John Frederick | Amministratore | Orchard Farmhouse Cowfold Lane Rotherwick RG27 9BP Hook Hampshire | British | 63211360001 | ||||||
| HARRIS, Anthony Beauchamp | Amministratore | 1 Norland Road Clifton BS8 3LP Bristol Avon | United Kingdom | British | 10913260001 | |||||
| HAYWOOD, William Sothern | Amministratore | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | 134536420001 | |||||
| INTERNATIONAL, Senoble | Amministratore | Place Du Champ De Mars Brussels 1050 5 Belgium | Belgium | English | 176921600001 | |||||
| JOHNSON, Andrew Bainbridge | Amministratore | The Old Rectory 15 High Street LE15 9DN Morcott Leicestershire | United Kingdom | British | 97381620001 | |||||
| MARSHALL, Christopher Miller | Amministratore | Field House 3 Dovecote Drive Welton LN2 3UA Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 61955820001 | |||||
| MOORHOUSE, Robert Thomas | Amministratore | 1 Glebeland Close Thrussington LE7 4TT Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 61955460001 | |||||
| OWEN, David Jeremy, Mbe | Amministratore | The Old Rectory Birdingbury CV23 8EW Rugby Warwickshire | England | British | 27576480001 | |||||
| OWEN, Ena Emily | Amministratore | Harrow Lodge West Avenue Stoke Park Coventry West Midlands | British | 27576520001 | ||||||
| OWEN, Hilary Patricia | Amministratore | The Old Rectory Birdingbury CV23 8EW Rugby Warwickshire | British | 27576510001 | ||||||
| OWEN, Julian Christopher | Amministratore | The Old Mill Tredington CV36 4NJ Shipston On Stour Warwickshire | England | British | 73549290001 | |||||
| PECK, Andy | Amministratore | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | England | British | 184282610001 | |||||
| PIERRARD, Jean-Christophe | Amministratore | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | French | 158294970001 | |||||
| PORTERGILL, Richard George | Amministratore | Upway Highmoor Cross RG9 5DT Henley On Thames Oxfordshire | British | 2563880001 | ||||||
| SALAMON, Francois | Amministratore | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 136452470001 | |||||
| SENOBLE, Marc | Amministratore | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 124986450001 | |||||
| TISSEAU, Pascal Louis Alphonse Joseph | Amministratore | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 136452410002 | |||||
| VALDHER, Eric | Amministratore | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | England | French | 149457870001 | |||||
| WOOD, Joseph Anthony | Amministratore | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | England | British | 218325180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth The Chef Holdings Limited | 01 nov 2017 | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mr Marc Claude Andre Senoble | 06 apr 2016 | Rue Du Pepin Brussels 31/37 Belgium | Sì | ||||||||||
Nazionalità: French Paese di residenza: Belgium | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0