HDL (CATERING) LIMITED

HDL (CATERING) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHDL (CATERING) LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 01561361
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HDL (CATERING) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova HDL (CATERING) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HDL (CATERING) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SEDDONS FOODS LIMITED26 feb 198826 feb 1988
    SEDDONS-PALATINE LIMITED14 mag 198114 mag 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di HDL (CATERING) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HDL (CATERING) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HDL (CATERING) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    CERTIPS

    Varie

    Forms b & z to convert to i&ps
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 17/06/2011
    RES13

    Nomina di Mr Steven Clive Bailey come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Humes come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 lug 2011

    Stato del capitale al 21 lug 2011

    • Capitale: GBP 1,416
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Humes il 01 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hurrell il 01 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2010

    4 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 11 gen 2010 al 02 gen 2010

    1 pagineAA01

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katherine Eldridge come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 10 gen 2009

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 12 gen 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HDL (CATERING) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Segretario
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150084390001
    BAILEY, Steven Clive
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish99724260001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Segretario
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    British10084840001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Segretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Segretario
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UNITED CO OPERATIVES SECRETARY LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110061750001
    ASPRAY, Rodney George
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    British2637360001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    FLITCROFT, Kevin
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    British13792010001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HUNT, Walter Kenneth
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    British9318100001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KNOWLES, John Keith
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    British13791990001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    MCGOERN, Alan
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    British28940610001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Amministratore
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    STEVENSON, Brian
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    British13792000001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UNITED CO OPERATIVES DIRECTOR 1 LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110062190001

    HDL (CATERING) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a wesley mill, bamber bridge, preston, lancs.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 12 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 12 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands hereditaments and premises being wesley mill off club street bamber bridge preston.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 22 ago 1988
    Consegnato il 23 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All & singular the chattels, plant, machinery & terms described on form 395 (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 23 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 11 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way fo legal mortgage:- f/hold land together with the buildings erected thereon situate off club street, bamber bridge south ribble lancs. Together with a right of way over and along the adjoining roadway leading to club st aforesaid fixed charge over plant, machienry implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 26 feb 1988
    Consegnato il 18 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Upk 55,000 one pound 5% second debenture loan stock and all monies due supplemental to a loan stock agreement of even date.
    Brevi particolari
    All freehold & leasehold property, goodwill, book debts, undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • John Keith Knowles
    Transazioni
    • 18 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 apr 1984
    Consegnato il 09 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge and undertaking and all property and assets present and future including godwill book & other debts uncalled capital. Together with all fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 27 mag 1981
    Consegnato il 02 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0