SAWP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSAWP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01565544
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SAWP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SAWP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loudwater Mill
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SAWP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUTHERN AND WESTERN PRESS LIMITED15 nov 198415 nov 1984
    SURREY PROPERTY MAIL LIMITED02 giu 198102 giu 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di SAWP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SAWP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 28 mar 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c and capital reserve 09/03/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 25 dic 2016

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2016

    Stato del capitale al 19 mag 2016

    • Capitale: GBP 13,557.05
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 26 nov 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2015

    Stato del capitale al 18 mag 2015

    • Capitale: GBP 13,557.05
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Simon Alton Westrop il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Henry Kennedy Faure Walker il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 11 dic 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Paul Davidson come amministratore in data 11 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2014

    Stato del capitale al 07 mag 2014

    • Capitale: GBP 13,557.05
    SH01

    Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SAWP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishFinance Director69320190004
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Segretario
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    British7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    GLASS, Josephine Mary
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    Segretario
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    British44504060001
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Segretario
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    TOWNSEND, John Arthur
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    Segretario
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    British7332310001
    AIKEN, Iain William
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    Amministratore
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    BritishNewspaper Publisher83849650001
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Amministratore
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    BritishCompany Secretary7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    BritishNewspaper Chief Exec4154210013
    CHRISTIE, David Gordon
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    BritishNewspaper Publisher75461250001
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46356560004
    GRAHAM, John Stuart
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    Amministratore
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    BritishChartered Accountant72224100001
    HARRIS, Philip James
    18 Palairet Close
    BA15 1US Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    18 Palairet Close
    BA15 1US Bradford On Avon
    Wiltshire
    BritishNewspaper Director26617980001
    MATTHEWS, David John
    17 Orwell Drive
    Keynsham
    BS18 1QB Bristol
    Avon
    Amministratore
    17 Orwell Drive
    Keynsham
    BS18 1QB Bristol
    Avon
    BritishAccountant26617990001
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Amministratore
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritishFinance Director93412530001
    RADBURN, Philip Arthur
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46357310001
    SKINNER, Peter John
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    Amministratore
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    BritishChartered Accountant7332340001
    STEVENSON, Hew Shannan
    42 Canonbury Square
    N1 2AW London
    Amministratore
    42 Canonbury Square
    N1 2AW London
    BritishNewspaper Director8030630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SAWP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    06 apr 2016
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01676637
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SAWP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 01 giu 1989
    Consegnato il 10 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land & buildings situated as southover wells somerset together with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 giu 1989
    Consegnato il 10 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 gen 1989
    Consegnato il 14 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a southover wells, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1989
    Consegnato il 03 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £420,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land & buildings situate at southover at wells in the county of somerset.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 06 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a southern wills, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1987
    Consegnato il 06 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 30 dic 1986
    Consegnato il 20 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge over bookdebts
    Creato il 14 mar 1985
    Consegnato il 22 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be owing the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 ago 1982
    Consegnato il 03 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts, floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0