SAWP LIMITED
Panoramica
Nome della società | SAWP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01565544 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SAWP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SAWP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SAWP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SOUTHERN AND WESTERN PRESS LIMITED | 15 nov 1984 | 15 nov 1984 |
SURREY PROPERTY MAIL LIMITED | 02 giu 1981 | 02 giu 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SAWP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 25 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per SAWP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 mar 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 25 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 26 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 13 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 13 gen 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Simon Alton Westrop il 13 gen 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Henry Kennedy Faure Walker il 13 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 11 dic 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Davidson come amministratore in data 11 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SAWP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Segretario | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Segretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Finance Director | 69320190004 | ||||
BLACKNELL, David | Segretario | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
BRESNARK, Lawrence | Segretario | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
GLASS, Josephine Mary | Segretario | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Segretario | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
TOWNSEND, John Arthur | Segretario | 36 Guithavon Road CM8 1HD Witham Essex | British | 7332310001 | ||||||
AIKEN, Iain William | Amministratore | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
BLACKNELL, David | Amministratore | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | Company Secretary | 7332320001 | |||||
BRESNARK, Lawrence | Amministratore | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
BROWN, James Thomson | Amministratore | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Exec | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Amministratore | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Newspaper Publisher | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Amministratore | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
GRAHAM, John Stuart | Amministratore | 10 Hatley Close Friern Barnet N11 3LN London | British | Chartered Accountant | 72224100001 | |||||
HARRIS, Philip James | Amministratore | 18 Palairet Close BA15 1US Bradford On Avon Wiltshire | British | Newspaper Director | 26617980001 | |||||
MATTHEWS, David John | Amministratore | 17 Orwell Drive Keynsham BS18 1QB Bristol Avon | British | Accountant | 26617990001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Amministratore | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Amministratore | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
SKINNER, Peter John | Amministratore | 22 Beresford Gardens SS7 2SA Hadleigh Essex | British | Chartered Accountant | 7332340001 | |||||
STEVENSON, Hew Shannan | Amministratore | 42 Canonbury Square N1 2AW London | British | Newspaper Director | 8030630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SAWP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 06 apr 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SAWP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creato il 01 giu 1989 Consegnato il 10 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land & buildings situated as southover wells somerset together with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 giu 1989 Consegnato il 10 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 26 gen 1989 Consegnato il 14 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a southover wells, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 gen 1989 Consegnato il 03 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £420,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H land & buildings situate at southover at wells in the county of somerset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 02 mar 1987 Consegnato il 06 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a southern wills, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1987 Consegnato il 06 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 dic 1986 Consegnato il 20 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over bookdebts | Creato il 14 mar 1985 Consegnato il 22 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be owing the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 27 ago 1982 Consegnato il 03 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all book debts and other debts, floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0