OLDCO (NO.1) LIMITED
Panoramica
Nome della società | OLDCO (NO.1) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01565718 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OLDCO (NO.1) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova OLDCO (NO.1) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 Old Broad Street EC2N 1AD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OLDCO (NO.1) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SBJ GROUP ADMINISTRATION LIMITED | 20 dic 1990 | 20 dic 1990 |
W S MOODY HOLDINGS LIMITED | 02 ago 1985 | 02 ago 1985 |
W.S. MOODY (HOLDINGS) LIMITED | 02 giu 1981 | 02 giu 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OLDCO (NO.1) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per OLDCO (NO.1) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 04 dic 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Graham Bobby il 24 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge come amministratore in data 14 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Susan Nicola Teale come amministratore in data 14 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Graham Harvey come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di OLDCO (NO.1) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMALL, Jeremy Peter | Segretario | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | British | 135642970001 | ||||||
BOBBY, Christopher Graham | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | None | 170592990002 | ||||
TEALE, Susan Nicola | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | None | 217659080001 | ||||
BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Segretario | Turret Grove Clapham SW4 0ES London 25 | United Kingdom | 1464480001 | ||||||
COLE, Simon Lawrence Vernon | Segretario | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | 50520880006 | ||||||
COLE, Simon Lawrence Vernon | Segretario | 10 Clarence Road Wimbledon SW19 8QE London | British | 50520880002 | ||||||
WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Whitechapel Road E1 1JG London One Hundred Whitechapel | 130133160001 | |||||||
WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | 100 Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | 68360510001 | |||||||
ANDERSON, Philip John | Amministratore | 1 Warmans Close Bawburgh NR9 3JB Norwich Norfolk | Uk | British | Fd | 79136250001 | ||||
BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Chartered Accountant | 1464480002 | |||||
BIRRELL, Christopher Ros Stewart | Amministratore | Turret Grove Clapham SW4 0ES London 25 | England | United Kingdom | Chartered Accountant | 1464480001 | ||||
BODEN, George | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | United Kingdom | British | Insurance Broker | 149286650001 | ||||
BODEN, George | Amministratore | Flat 4 4 Onslow Gardens SW7 3LX London | British | Insurance Broker | 2338580002 | |||||
CLARK, James Albert | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Insurance Broker | 6514930003 | |||||
COLE, Simon Lawrence Vernon | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Chartered Secretary | 50520880006 | |||||
GRAY, Peter | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Insurance Pensions Consultant | 2358790002 | |||||
HARVEY, Graham | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | Company Director | 168974600001 | ||||
HOLT, Antony Vincent | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | Accountant | 190351400001 | ||||
KEYS, Anthony James | Amministratore | 63 Pont Street SW1X 0BD London | United Kingdom | British | Finance Director | 2338570001 | ||||
POUPART-LAFARGE, Bertrand | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | French | Company Director | 174977050001 | ||||
STEEPLES, Howard | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Insurance Broker | 11084310002 | |||||
VINTEN, Duncan James Gordon | Amministratore | One Hundred Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | British | Insurance Broker | 26608710003 | |||||
WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Whitechapel Road E1 1JG London One Hundred Whitechapel | 130132980001 | |||||||
WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 100 Whitechapel Whitechapel Road E1 1JG London | 68360650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OLDCO (NO.1) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thinc Uk Group Limited | 06 apr 2016 | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OLDCO (NO.1) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 11 lug 2007 Consegnato il 18 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed in respect of a mortgage debenture and a composite guarantee both dated 9 june 1999 issued by the company | Creato il 31 dic 2001 Consegnato il 10 gen 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 09 giu 1999 Consegnato il 19 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over credit balances | Creato il 25 nov 1997 Consegnato il 05 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The sum of £1,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 46156178 and earmarked by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over credit balances | Creato il 14 mar 1986 Consegnato il 27 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from keith macdonald smith to the chargee not exceeding £15,000 | |
Brevi particolari All moneys from time to time held to yhe credit of the company by national westminster bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the company may now and/or hereafter have with national westminster bank PLC and/or under any deposit receipt. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over credit balances | Creato il 04 set 1985 Consegnato il 17 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from P.F. lovelock to the chargee not exceeding £17,500 | |
Brevi particolari All moneys from time to time held to the credit of the company (please see doc M12 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over credit balances | Creato il 07 gen 1985 Consegnato il 21 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from peter frederick lovelock to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys from time to time held to the credit of the company by national westminister bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the co may now or/and hereafter have with national westminsiter bank PLC and/or under any deposit receipt. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0