OLDCO (NO.1) LIMITED

OLDCO (NO.1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLDCO (NO.1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01565718
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLDCO (NO.1) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SBJ GROUP ADMINISTRATION LIMITED20 dic 199020 dic 1990
    W S MOODY HOLDINGS LIMITED02 ago 198502 ago 1985
    W.S. MOODY (HOLDINGS) LIMITED02 giu 198102 giu 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A8DBYU4R

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X7XFG9QO

    legacy

    1 pagineSH20
    L7JZYQNS

    Stato del capitale al 04 dic 2018

    • Capitale: GBP 0.10
    3 pagineSH19
    L7JZYQPC

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    L7JZYQPS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of capital redemption reserve account 23/11/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA
    L7F75D00

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Graham Bobby il 24 apr 2018

    2 pagineCH01
    X74OO1AI

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X6XY9XMG

    Cessazione della carica di Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge come amministratore in data 14 lug 2017

    1 pagineTM01
    X6ATXYUH

    Nomina di Mrs Susan Nicola Teale come amministratore in data 14 lug 2017

    2 pagineAP01
    X6ATXYQ1

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    19 pagineAA
    L6A1H2WX

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X68L85OQ

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X5YB6JSW

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    19 pagineAA
    L5AII9LV

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mag 2016

    Stato del capitale al 17 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,778,932.1
    SH01
    X575L9MH

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA
    A4A8ER17

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2015

    Stato del capitale al 15 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,778,932.1
    SH01
    X47HGQWO

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA
    L3H83PAH

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2014

    Stato del capitale al 15 mag 2014

    • Capitale: GBP 1,778,932.1
    SH01
    X37XDNB7

    Nomina di Mr Bertrand Marie Jean Olivier Poupart-Lafarge come amministratore

    3 pagineAP01
    A2NM1PO8

    Cessazione della carica di Graham Harvey come amministratore

    1 pagineTM01
    X2NN25TT

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD
    R2LDLY23

    Chi sono gli amministratori di OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British135642970001
    BOBBY, Christopher Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishNone170592990002
    TEALE, Susan Nicola
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritishNone217659080001
    BIRRELL, Christopher Ros Stewart
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    Segretario
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    United Kingdom1464480001
    COLE, Simon Lawrence Vernon
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Segretario
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    British50520880006
    COLE, Simon Lawrence Vernon
    10 Clarence Road
    Wimbledon
    SW19 8QE London
    Segretario
    10 Clarence Road
    Wimbledon
    SW19 8QE London
    British50520880002
    WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    One Hundred Whitechapel
    Segretario
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    One Hundred Whitechapel
    130133160001
    WHITECHAPEL CORPORATE SECRETARY LIMITED
    100 Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Segretario
    100 Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    68360510001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFd79136250001
    BIRRELL, Christopher Ros Stewart
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishChartered Accountant1464480002
    BIRRELL, Christopher Ros Stewart
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    Amministratore
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant1464480001
    BODEN, George
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritishInsurance Broker149286650001
    BODEN, George
    Flat 4
    4 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    Amministratore
    Flat 4
    4 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    BritishInsurance Broker2338580002
    CLARK, James Albert
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishInsurance Broker6514930003
    COLE, Simon Lawrence Vernon
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishChartered Secretary50520880006
    GRAY, Peter
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishInsurance Pensions Consultant2358790002
    HARVEY, Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishCompany Director168974600001
    HOLT, Antony Vincent
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritishAccountant190351400001
    KEYS, Anthony James
    63 Pont Street
    SW1X 0BD London
    Amministratore
    63 Pont Street
    SW1X 0BD London
    United KingdomBritishFinance Director2338570001
    POUPART-LAFARGE, Bertrand
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomFrenchCompany Director174977050001
    STEEPLES, Howard
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishInsurance Broker11084310002
    VINTEN, Duncan James Gordon
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    BritishInsurance Broker26608710003
    WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    One Hundred Whitechapel
    Amministratore
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    One Hundred Whitechapel
    130132980001
    WHITECHAPEL CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    100 Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    100 Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    68360650001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OLDCO (NO.1) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5936990
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OLDCO (NO.1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed in respect of a mortgage debenture and a composite guarantee both dated 9 june 1999 issued by the company
    Creato il 31 dic 2001
    Consegnato il 10 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 19 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 25 nov 1997
    Consegnato il 05 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £1,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 46156178 and earmarked by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 14 mar 1986
    Consegnato il 27 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from keith macdonald smith to the chargee not exceeding £15,000
    Brevi particolari
    All moneys from time to time held to yhe credit of the company by national westminster bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the company may now and/or hereafter have with national westminster bank PLC and/or under any deposit receipt.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 04 set 1985
    Consegnato il 17 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from P.F. lovelock to the chargee not exceeding £17,500
    Brevi particolari
    All moneys from time to time held to the credit of the company (please see doc M12 for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 07 gen 1985
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from peter frederick lovelock to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys from time to time held to the credit of the company by national westminister bank PLC on any current deposit and/or other account or accounts which the co may now or/and hereafter have with national westminsiter bank PLC and/or under any deposit receipt.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0