RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED

RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01566804
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAPIO HEALTHCARE UK LIMITED05 nov 200105 nov 2001
    COMMUNITY HOSPITALS GROUP LIMITED31 mag 198831 mag 1988
    COMMUNITY HOSPITALS PLC08 giu 198108 giu 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 mar 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 apr 2009

    LRESSP

    legacy

    3 pagine88(3)

    legacy

    2 pagine88(2)

    legacy

    1 pagineSH20

    Varie

    11/05/09 reduced from 39363902 to 2 mem of capital
    1 pagineMISC

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium red by £14,554,954 14/04/2009
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine122

    Risoluzioni

    Resolutions
    48 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    £2784335 14/04/2009
    RES14

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    9 pagine155(6)b

    legacy

    9 pagine155(6)b

    legacy

    9 pagine155(6)b

    legacy

    9 pagine155(6)b

    legacy

    9 pagine155(6)a

    Chi sono gli amministratori di RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALE, Andrew Michael
    24 Godwin Way
    Bromham
    MK43 8JH Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    24 Godwin Way
    Bromham
    MK43 8JH Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant78611560001
    MEHTA, Hiten
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector78629780001
    WATTS, Jill Margaret
    Shad Thames
    SE1 2YE London
    403 Butlers Wharf 36
    Amministratore
    Shad Thames
    SE1 2YE London
    403 Butlers Wharf 36
    Great BritainBritishDirector162338280001
    CROKER, David Geoffrey
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director62363640001
    MEHTA, Hiten
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    23 Nagle Grove
    Rusheymead
    LE4 7RU Leicester
    Leicestershire
    British78629780001
    NEWBERY, Richard Charles William
    25 De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    25 De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    Cambridgeshire
    British40606130001
    NORRIS, David William
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    25 Mandeville Road
    SG13 8JQ Hertford
    Hertfordshire
    BritishAccountant26898620002
    OCOWNELI, Kevin Daniel
    82 Bull Stag Green
    Hatfield
    AL9 5DE St Albans
    Herts
    Segretario
    82 Bull Stag Green
    Hatfield
    AL9 5DE St Albans
    Herts
    British32438330001
    WILLISCROFT, John Edwin
    12 Chapel Fields
    SG18 0ND Biggleswade
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Chapel Fields
    SG18 0ND Biggleswade
    Bedfordshire
    British48428880001
    BATELSON, Per Gunnar
    Kungsgatan 16
    Marstrand
    Se-400 30
    Sweden
    Amministratore
    Kungsgatan 16
    Marstrand
    Se-400 30
    Sweden
    SwedenSwedishDirector181830090001
    BAXENDALE, Raymond
    Burleigh House
    1 The Waits
    PE27 5BY St. Ives
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Burleigh House
    1 The Waits
    PE27 5BY St. Ives
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManaging Director76722180001
    BRODEN, Jan Stanley
    Hasttorget 2
    Laholm
    Se 312 30
    Sweden
    Amministratore
    Hasttorget 2
    Laholm
    Se 312 30
    Sweden
    SwedishDirector79016500001
    CARLSON, Per Henrik Staffan
    Ramansgatan 30
    Se-44230 Kungalr
    Sweden
    Amministratore
    Ramansgatan 30
    Se-44230 Kungalr
    Sweden
    SwedishCfo86496780001
    CROKER, David Geoffrey
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    5 Willow Close
    Brampton
    PE18 8RJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    UkBritishFinance Director62363640001
    DEXTER, Alan Michael
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    Amministratore
    42 Stone Hall Road
    Winchmore Hill
    N21 1LP London
    EnglandBritishChairman32438340001
    ELSIGOOD, Timothy James
    8 Beech Drive
    PE9 4EW Ryhall
    Stamford Lincolnshire
    Amministratore
    8 Beech Drive
    PE9 4EW Ryhall
    Stamford Lincolnshire
    BritishManaging Director78191450001
    FRIMAN, Anders
    Tystbergavagen 17
    Enskede
    Se-122 41
    Sweden
    Amministratore
    Tystbergavagen 17
    Enskede
    Se-122 41
    Sweden
    SwedishDirector118687660001
    HEMMING ALLEN, Myra Jennifer
    The Coach House
    19 Church Street
    PE19 5SJ Buckden
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Coach House
    19 Church Street
    PE19 5SJ Buckden
    Cambridgeshire
    BritishDirector-Human Resources73808030001
    HILLIER, David
    73 Klea Avenue
    SW4 9HZ London
    Amministratore
    73 Klea Avenue
    SW4 9HZ London
    BritishCeo117837850002
    HODGSON, Robin Granville, Lord
    15 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    Amministratore
    15 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    EnglandBritishCompany Director78181310001
    HOKFELT, Paul
    4 Ch Prcs-Courts
    Vesenaz
    Ch-1222
    Switzerland
    Amministratore
    4 Ch Prcs-Courts
    Vesenaz
    Ch-1222
    Switzerland
    SwedishCeo118687560001
    MANN, Thomas Joseph, Dr
    42 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    42 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive95641850001
    MATTSSON, Ulf Sven Ivar
    Gotabergsgatan 22
    Goteborg
    Se-411 34
    Sweden
    Amministratore
    Gotabergsgatan 22
    Goteborg
    Se-411 34
    Sweden
    SwedeCeo113105270001
    MCCUTHCHEON, Ian Crawford
    Saplings 1 Spicers Field
    KT22 0UT Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Saplings 1 Spicers Field
    KT22 0UT Oxshott
    Surrey
    BritishDirector32438380001
    ODONOGHUE, Neil
    Flat 14 20 Queen Annes Terrace
    W1N London
    Amministratore
    Flat 14 20 Queen Annes Terrace
    W1N London
    IrishConsultant Urological Surgeon32438390001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive11755290002
    PRENTICE, Oliver John
    Mill Farm Cottage
    Westbury
    NN13 5JS Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Mill Farm Cottage
    Westbury
    NN13 5JS Brackley
    Northamptonshire
    BritishManaging Director-Continuing C28269820003
    RUDDELL, Michael Frith
    Pelham Lodge Clifton Lane
    Ruddington
    NG11 6AB Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Pelham Lodge Clifton Lane
    Ruddington
    NG11 6AB Nottingham
    Nottinghamshire
    IrishDirector9723520001
    SIMONDS-GOODING, Anthony James Joseph
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Burchetts Brook
    Holmbury St Mary
    RH5 6NA Dorking
    Surrey
    BritishCompany Director50867110002
    SJOSTEDT, Dwight
    68j Randolphs Avenue
    Little Venice
    W9 London
    Amministratore
    68j Randolphs Avenue
    Little Venice
    W9 London
    SwedishChief Executive105414850001
    STOCK, Linda
    Rose Cottage
    Aston Ingham Road Kilcot
    GL18 1NS Newent
    Gloucestershire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Aston Ingham Road Kilcot
    GL18 1NS Newent
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector104973300001
    SVALSTEDT, Carl Martin
    Varpmossevagen 30
    Askim
    Se-436 39
    Sweden
    Amministratore
    Varpmossevagen 30
    Askim
    Se-436 39
    Sweden
    SwedishDirector76029430001
    THOMPSON, Peter Anthony, Sir
    The Mill House
    MK16 8ER Newport Pagnell
    Bucks
    Amministratore
    The Mill House
    MK16 8ER Newport Pagnell
    Bucks
    EnglandBritishChairman809410001
    TINCKHAM, Loretta Fay
    Lion House
    Great Bircham
    PE31 6RJ King's Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Lion House
    Great Bircham
    PE31 6RJ King's Lynn
    Norfolk
    BritishExecutive Director95319780001
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritishDirector82667700001

    RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right, title and interest in and to each of the following assets being the real property; and the investments; and by way of first floating charge all present and future assets and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee)
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge between the company and deutsche bank ag london as security agent for itself and the finance parties (the security agent)
    Creato il 21 set 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the security agent under or in respect of the senior facility agreement dated 26TH april 2001 the guarantee given by the chargor under the facility agreement or the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares between the chargor and deutsche bank ag london as security agent for itself and for and on behalf of the finance parties (the security agent)
    Creato il 21 set 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All and any amounts of any kind now or in the future due payable by the chargor to any of the finance parties under or in connection with the facility agreement dated 26TH april 2001 (as amended) or the guarantee given by the chargor under the facility agreement or the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the original securities and any other which the chargor may substitute for all or any of the original securities and all other securities rights moneys (including without limitation dividends) and property which may be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 29 giu 2001
    Consegnato il 11 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note guarantee dated 3 february 1998
    Brevi particolari
    The sum of £2,400,ooo together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8910219 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account and counterpart
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 13 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies paid by the company into the charged account which may be released to the chargee under the terms of the agreement for lease
    Brevi particolari
    The interest bearing sterling deposit account number 51813556 at national westminster bank PLC 81 high street bedford.
    Persone aventi diritto
    • Chg Homes PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RAMSAY HEALTH CARE INVESTMENTS UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 apr 2009Inizio della liquidazione
    23 giu 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew John Waghorn
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Berkshire
    Praticante
    Highlands House Basingstoke Road
    Spencers Wood
    RG7 1NT Reading
    Berkshire
    David William Tann
    Nortons Recovery Limited
    Highlands House
    RG7 1NT Basingstoke Road
    Spencers Wood Reading
    Praticante
    Nortons Recovery Limited
    Highlands House
    RG7 1NT Basingstoke Road
    Spencers Wood Reading

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0