ANS LIMITED
Panoramica
Nome della società | ANS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01569256 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ANS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1 Angel Court EC2R 7HJ London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ANS PLC | 16 feb 2004 | 16 feb 2004 |
ANS LIMITED | 19 dic 2003 | 19 dic 2003 |
ANS PLC | 27 giu 2003 | 27 giu 2003 |
ANS LIMITED | 06 giu 2003 | 06 giu 2003 |
ANS PLC | 25 ago 1999 | 25 ago 1999 |
ASSOCIATED NURSING SERVICES PLC | 14 gen 1985 | 14 gen 1985 |
A.N.S. LIMITED | 22 giu 1981 | 22 giu 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANS LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ANS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 20 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 20 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ANS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Rebecca Pearson come amministratore in data 03 feb 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Thomas Nichol Hoosen-Webber come amministratore in data 03 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 5 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Michael Harrison come amministratore in data 31 lug 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Neil Stephen Barker come amministratore in data 31 lug 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Rebecca Pearson come amministratore in data 31 lug 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 14 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Stephen Picken come amministratore in data 27 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Michael Harrison come amministratore in data 27 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Stephen Picken il 08 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 1 Angel Court London EC2R 7HJ | 1 pagine | AD04 | ||
Modifica dei dettagli di Ans 2003 Limited come persona con controllo significativo il 08 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Bupa Secretaries Limited il 08 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||
Chi sono gli amministratori di ANS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUPA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | 107319700001 | |||||||||||
BARKER, Neil Stephen | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British | Company Director | 159087650001 | ||||||||
HOOSEN-WEBBER, Thomas Nichol | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 249384870003 | ||||||||
BUPA SECRETARIES LIMITED | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
KING, Robert Frederick | Segretario | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||||||
VENUS, David Anthony | Segretario | 86 Park Road KT2 5JZ Kingston Upon Thames Surrey | British | 38563740001 | ||||||||||
BEAZLEY, Nicholas Tetley | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Director | 105797560001 | ||||||||
CANNON, Andrew John | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | Company Director | 200461360001 | ||||||||
DALY, Geoffrey William Stuart | Amministratore | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 19464860003 | ||||||||
DAVIES, Julian Peter | Amministratore | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 29367700001 | ||||||||
DHANDSA, Narinder, Dr | Amministratore | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | Company Director | 115844000001 | ||||||||
DHANDSA, Surindar | Amministratore | 14 Canons Close PO21 4EB Bognor Regis West Sussex | United Kingdom | British | Director | 109934070001 | ||||||||
ELLERBY, Mark | Amministratore | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 40582650004 | ||||||||
GREGORY, Fraser David | Amministratore | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 107664270003 | ||||||||
HARRISON, Michael | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 241166230001 | ||||||||
HODSON, John | Amministratore | Little Chittenden Four Elms TN8 6PB Edenbridge Kent | England | British | Merchant Banker | 712040001 | ||||||||
KENT, Benjamin David Jemphrey | Amministratore | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 93897360003 | ||||||||
KING, Robert Frederick | Amministratore | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | Solicitor | 10012650001 | |||||||||
LOS, Steven Michael | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Company Director | 116895800001 | ||||||||
MACFARLANE, David Neil, Sir | Amministratore | Beechwood 11 Breedons Hill Pangbourne RG8 7AT Reading Berkshire | British | Company Director | 66616360002 | |||||||||
MERCHANT, Mahboob Ali | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 56732410001 | ||||||||
MOORE, Keith | Amministratore | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 49217290002 | ||||||||
PATEL, Anoop Kumar Nandubhai | Amministratore | 28 Avenue Paul De Jaer Apartment 3 St Gilles FOREIGN Brussels 1060 Belgium | Belgium | British | Director | 106955760001 | ||||||||
PEARSON, Rebecca | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 245936140002 | ||||||||
PICKEN, Jonathan Stephen | Amministratore | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 189611450001 | ||||||||
REITER, Simon Philip | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Finance Director | 135845570001 | ||||||||
ROBINSON, Anthony Leake | Amministratore | The Rose Garden Orchehill Avenue SL9 8QE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 48323880002 | |||||||||
SINCLAIR BROWN, Frederick John | Amministratore | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 8070730003 | ||||||||
STOREY, Roger Christopher | Amministratore | 11 Newlands SG6 2JE Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 1663050001 | ||||||||
TAYLOR, Neil Robert | Amministratore | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 62846800003 | ||||||||
THOMAS, Oliver Henry Dixon | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | Regional Director | 256549290001 | ||||||||
UPSDELL, Robert Stanley | Amministratore | Dragon Wyck Camp Road SL9 7PB Gerrards Cross Bucks | British | Director | 36094270002 | |||||||||
WALFORD, Arthur David | Amministratore | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 6658190001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ans 2003 Limited | 06 apr 2016 | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ANS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A standard security which was presented for registration in scotland on 16 january 2004 and | Creato il 09 gen 2004 Consegnato il 30 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee (for own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Subjects on the north east side of nitshill road, glasgow k/a and forming darnley court nursing centre, 787 nitshill road, glasgow t/no GLA94414. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 gen 2004 Consegnato il 14 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 4TH may 2001 | Creato il 26 apr 2001 Consegnato il 19 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether on its own account or as trustee or the secured parties)(as defined) or any of the other secured parties including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (both as defined) | |
Brevi particolari Property k/a all and whole the subjects situated on the north east side of nitshill road glasgow k/a and forming darnley court nursing home 787 nitshill road glasgow - GLA94414. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture between the company and the chargee as trustee for the secured parties (as defined) | Creato il 28 mar 2001 Consegnato il 11 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties including any liability under the facilities or the mezzanine loan facility (both as defined) whether present or future actual or contingent | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security which was presented for registration on 5TH september 2000 and also | Creato il 05 set 2000 Consegnato il 22 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums of money due or to become due from ans contract healthcare limited to the chargee in terms of a personal bond dated 29 march 2000 and registered in the books of council and session on 23 august 2000 | |
Brevi particolari All those subjects on north east side of nitshill rd,glasgow; t/no gla 94414. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Shares charge | Creato il 29 set 1999 Consegnato il 07 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and calverguild limited (the "borrowers") to the chargee under or in connection with the agreement dated 29 september 1999 or any security document (as defined) and all liabilities of the company under the charge | |
Brevi particolari 4,900 bc bank PLC "a" ordinary shares, 3,200 "b" ordinary shares 1,900 "c" ordinary shares each of £0.50 each in the issued share capital of the company and 2 ordinary shares of £1.00 each in the issued share capital of calverguild limited and all dividends interest and other money in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and assignment | Creato il 09 lug 1998 Consegnato il 20 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or ans contract healthcare (east sussex) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari An agreement dated 3RD march 1994 relating to kestrel house nursing home 220 willingdon road eastbourne east sussex , the polegate nursing home blackpath road polegate east sussex copper beech nursing home eastbourne road ridgewood uckfield east sussex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creato il 08 mag 1997 Consegnato il 21 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All sums of money paid by the chargor to the credit of the account(s) with the bank. Account no.60832189. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 mag 1997 Consegnato il 14 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All right,title and interest in account no.00134537 In the name of associated nursing services PLC and held with the governor and company of the bank of scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 lug 1996 Consegnato il 22 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land t/no 96649 k/as 138/140 little ilford lane manor park london E12 assignment over the benefit of all licences all compensation payable the goodwill of the business the benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of a building contract | Creato il 03 lug 1996 Consegnato il 22 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a loan agreement dated 3RD july 1996 (as defined) and/or this deed | |
Brevi particolari The interest of the mortgagor under the building contract and the full benefit and advantage of all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 29 mar 1996 Consegnato il 02 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of an agreement dated 29TH march 1996 | |
Brevi particolari F/H land on the north side of high street chesterton cambridge t/no CB189356 together with the nursing home to be constructed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creato il 06 gen 1995 Consegnato il 25 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All sums of money paid by the chargor to the credit of the account with the bank. Account no.30286532. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of subordination | Creato il 23 dic 1994 Consegnato il 06 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The ultimate balance from time to time of the senior liabilities being all sums now or hereafter due, owing or incurred by ans contract healthcare (hartlepool) limited (the debtor) and shall be a continuing security until the discharge in full of the senior liabilities under the terms of the loan agreement (as defined) and the "finance documents" (as defined) | |
Brevi particolari Any payment or other distribution being made to, or right of set-off of the debtor liabilities against the subordinated liabilities being exercised by the subordinated creditors or the debtor contrary to the provisions of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over deposit account | Creato il 30 lug 1993 Consegnato il 19 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Brevi particolari The sum standing to the credit of the deposit account no 20519677. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over a deposit account | Creato il 30 lug 1993 Consegnato il 19 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Brevi particolari The sum standing to the credit of the deposit account no 20519693. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over deposit account | Creato il 30 lug 1993 Consegnato il 19 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Brevi particolari The sum from time to time standing to the credit of the deposit account no 20519685. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 lug 1993 Consegnato il 09 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Ham river house vicarage crescent battersea l/b of wandsworth t/no.SGL187063. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 26 mar 1993 Consegnato il 31 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity dated 26/03/93 | |
Brevi particolari Fixed charge over all deposits together with all interest for full details see form 395 ref M18. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 18 feb 1993 Consegnato il 01 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Nursing home site on west of carron road falkirk stirlingshire part of 3.6 acres site at carron road falkirk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 gen 1993 Consegnato il 25 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation | Creato il 16 ott 1992 Consegnato il 28 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to ans contract healthcare PLC pursuant to the terms of a lease agreement dated 24-9-92 and/or this charge. | |
Brevi particolari All sums due or to become due to the company pursuant to the terms of agreements dated 28-11-91 and 5-12-91 made between the company and the greater glasgow health board. Please see doc for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over sterling | Creato il 07 lug 1992 Consegnato il 08 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company and or mansionway limited the chargee under the guarantee and the facility letter | |
Brevi particolari The sum of £100000 including interest arising on the cash deposit and all the right title and interest therein. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 07 lug 1992 Consegnato il 08 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company and/or mansionway limited to the chargee under the guarantee and/or the facility letter | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 25 giu 1992 Consegnato il 02 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0