ANS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01569256
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ANS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ANS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Court
    EC2R 7HJ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANS PLC16 feb 200416 feb 2004
    ANS LIMITED19 dic 200319 dic 2003
    ANS PLC27 giu 200327 giu 2003
    ANS LIMITED06 giu 200306 giu 2003
    ANS PLC25 ago 199925 ago 1999
    ASSOCIATED NURSING SERVICES PLC 14 gen 198514 gen 1985
    A.N.S. LIMITED22 giu 198122 giu 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ANS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per ANS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Rebecca Pearson come amministratore in data 03 feb 2025

    1 pagineTM01
    XDW7L1QW

    Nomina di Mr Thomas Nichol Hoosen-Webber come amministratore in data 03 feb 2025

    2 pagineAP01
    XDW4Y0BK

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XD6K5X9N

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    5 pagineAA
    AD3QGN6O

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA
    AC94K1RF

    Cessazione della carica di Michael Harrison come amministratore in data 31 lug 2023

    1 pagineTM01
    XC94XDUX

    Nomina di Mr Neil Stephen Barker come amministratore in data 31 lug 2023

    2 pagineAP01
    XC8WQL17

    Nomina di Mrs Rebecca Pearson come amministratore in data 31 lug 2023

    2 pagineAP01
    XC8WQKZF

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XC62EY03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    4 pagineAA
    AB6QCJRV

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB6Q9JQ2

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA7CZ3VD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA
    AA100GVS

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X97RUAHV

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA
    A951XTEZ

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X883U2AI

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA
    A819W8JE

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA
    A7911SU2

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X78ZLY4A

    Cessazione della carica di Jonathan Stephen Picken come amministratore in data 27 apr 2018

    1 pagineTM01
    X750G2E3

    Nomina di Mr Michael Harrison come amministratore in data 27 apr 2018

    2 pagineAP01
    X750G27C

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Stephen Picken il 08 dic 2017

    2 pagineCH01
    X6KVBAEJ

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 1 Angel Court London EC2R 7HJ

    1 pagineAD04
    X6KVBZPK

    Modifica dei dettagli di Ans 2003 Limited come persona con controllo significativo il 08 dic 2017

    2 paginePSC05
    X6KVBXQI

    Dettagli del segretario cambiati per Bupa Secretaries Limited il 08 dic 2017

    1 pagineCH04
    X6KVBIAZ

    Chi sono gli amministratori di ANS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    107319700001
    BARKER, Neil Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director159087650001
    HOOSEN-WEBBER, Thomas Nichol
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director249384870003
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3155937
    162768400001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Segretario
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishDirector105797560001
    CANNON, Andrew John
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritishCompany Director200461360001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Amministratore
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Amministratore
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritishCompany Director115844000001
    DHANDSA, Surindar
    14 Canons Close
    PO21 4EB Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    14 Canons Close
    PO21 4EB Bognor Regis
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector109934070001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector107664270003
    HARRISON, Michael
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241166230001
    HODSON, John
    Little Chittenden
    Four Elms
    TN8 6PB Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Little Chittenden
    Four Elms
    TN8 6PB Edenbridge
    Kent
    EnglandBritishMerchant Banker712040001
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director93897360003
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Amministratore
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    BritishSolicitor10012650001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishCompany Director116895800001
    MACFARLANE, David Neil, Sir
    Beechwood 11 Breedons Hill
    Pangbourne
    RG8 7AT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Beechwood 11 Breedons Hill
    Pangbourne
    RG8 7AT Reading
    Berkshire
    BritishCompany Director66616360002
    MERCHANT, Mahboob Ali
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant56732410001
    MOORE, Keith
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant49217290002
    PATEL, Anoop Kumar Nandubhai
    28 Avenue Paul De Jaer Apartment 3
    St Gilles
    FOREIGN Brussels
    1060
    Belgium
    Amministratore
    28 Avenue Paul De Jaer Apartment 3
    St Gilles
    FOREIGN Brussels
    1060
    Belgium
    BelgiumBritishDirector106955760001
    PEARSON, Rebecca
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director245936140002
    PICKEN, Jonathan Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director189611450001
    REITER, Simon Philip
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishFinance Director135845570001
    ROBINSON, Anthony Leake
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector48323880002
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant8070730003
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director1663050001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritishChartered Accountant62846800003
    THOMAS, Oliver Henry Dixon
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritishRegional Director256549290001
    UPSDELL, Robert Stanley
    Dragon Wyck
    Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Bucks
    Amministratore
    Dragon Wyck
    Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Bucks
    BritishDirector36094270002
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor6658190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ANS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4755807
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ANS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16 january 2004 and
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 30 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (for own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects on the north east side of nitshill road, glasgow k/a and forming darnley court nursing centre, 787 nitshill road, glasgow t/no GLA94414.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 14 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 4TH may 2001
    Creato il 26 apr 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether on its own account or as trustee or the secured parties)(as defined) or any of the other secured parties including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (both as defined)
    Brevi particolari
    Property k/a all and whole the subjects situated on the north east side of nitshill road glasgow k/a and forming darnley court nursing home 787 nitshill road glasgow - GLA94414.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between the company and the chargee as trustee for the secured parties (as defined)
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties including any liability under the facilities or the mezzanine loan facility (both as defined) whether present or future actual or contingent
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration on 5TH september 2000 and also
    Creato il 05 set 2000
    Consegnato il 22 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums of money due or to become due from ans contract healthcare limited to the chargee in terms of a personal bond dated 29 march 2000 and registered in the books of council and session on 23 august 2000
    Brevi particolari
    All those subjects on north east side of nitshill rd,glasgow; t/no gla 94414.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares charge
    Creato il 29 set 1999
    Consegnato il 07 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and calverguild limited (the "borrowers") to the chargee under or in connection with the agreement dated 29 september 1999 or any security document (as defined) and all liabilities of the company under the charge
    Brevi particolari
    4,900 bc bank PLC "a" ordinary shares, 3,200 "b" ordinary shares 1,900 "c" ordinary shares each of £0.50 each in the issued share capital of the company and 2 ordinary shares of £1.00 each in the issued share capital of calverguild limited and all dividends interest and other money in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 07 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment
    Creato il 09 lug 1998
    Consegnato il 20 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or ans contract healthcare (east sussex) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement dated 3RD march 1994 relating to kestrel house nursing home 220 willingdon road eastbourne east sussex , the polegate nursing home blackpath road polegate east sussex copper beech nursing home eastbourne road ridgewood uckfield east sussex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 21 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums of money paid by the chargor to the credit of the account(s) with the bank. Account no.60832189. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All right,title and interest in account no.00134537 In the name of associated nursing services PLC and held with the governor and company of the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 22 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land t/no 96649 k/as 138/140 little ilford lane manor park london E12 assignment over the benefit of all licences all compensation payable the goodwill of the business the benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of a building contract
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 22 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a loan agreement dated 3RD july 1996 (as defined) and/or this deed
    Brevi particolari
    The interest of the mortgagor under the building contract and the full benefit and advantage of all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 02 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of an agreement dated 29TH march 1996
    Brevi particolari
    F/H land on the north side of high street chesterton cambridge t/no CB189356 together with the nursing home to be constructed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ans Contract Healthcare (Cambridge) Limited
    Transazioni
    • 02 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 06 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums of money paid by the chargor to the credit of the account with the bank. Account no.30286532. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of subordination
    Creato il 23 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The ultimate balance from time to time of the senior liabilities being all sums now or hereafter due, owing or incurred by ans contract healthcare (hartlepool) limited (the debtor) and shall be a continuing security until the discharge in full of the senior liabilities under the terms of the loan agreement (as defined) and the "finance documents" (as defined)
    Brevi particolari
    Any payment or other distribution being made to, or right of set-off of the debtor liabilities against the subordinated liabilities being exercised by the subordinated creditors or the debtor contrary to the provisions of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 19 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    The sum standing to the credit of the deposit account no 20519677.
    Persone aventi diritto
    • Johnson Fry NS22 PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over a deposit account
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 19 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    The sum standing to the credit of the deposit account no 20519693.
    Persone aventi diritto
    • Johnson Fry NS23 PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 19 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    The sum from time to time standing to the credit of the deposit account no 20519685.
    Persone aventi diritto
    • Johnson Fry NS21 PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1993
    Consegnato il 09 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ham river house vicarage crescent battersea l/b of wandsworth t/no.SGL187063.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 31 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity dated 26/03/93
    Brevi particolari
    Fixed charge over all deposits together with all interest for full details see form 395 ref M18.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 18 feb 1993
    Consegnato il 01 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Nursing home site on west of carron road falkirk stirlingshire part of 3.6 acres site at carron road falkirk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 gen 1993
    Consegnato il 25 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 25 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation
    Creato il 16 ott 1992
    Consegnato il 28 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to ans contract healthcare PLC pursuant to the terms of a lease agreement dated 24-9-92 and/or this charge.
    Brevi particolari
    All sums due or to become due to the company pursuant to the terms of agreements dated 28-11-91 and 5-12-91 made between the company and the greater glasgow health board. Please see doc for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ans Contract Healthcare PLC.
    Transazioni
    • 28 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sterling
    Creato il 07 lug 1992
    Consegnato il 08 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and or mansionway limited the chargee under the guarantee and the facility letter
    Brevi particolari
    The sum of £100000 including interest arising on the cash deposit and all the right title and interest therein.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 07 lug 1992
    Consegnato il 08 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and/or mansionway limited to the chargee under the guarantee and/or the facility letter
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 giu 1992
    Consegnato il 02 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0