D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED

D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01570577
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VALAD (ENFIELD) LIMITED18 set 200718 set 2007
    SDG (ENFIELD) LIMITED26 mar 200426 mar 2004
    SCARBOROUGH DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED22 ago 200022 ago 2000
    TEESLAND DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED29 set 199929 set 1999
    SCARBOROUGH PROPERTY COMPANY (ESSEX) LIMITED01 apr 199601 apr 1996
    SOUTHERN & CITY (PROJECT MANAGEMENT) LIMITED26 giu 198126 giu 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    20 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 11 mag 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 apr 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    24 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 24 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2016

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    24 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Edward Maddy il 12 nov 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 lug 2015

    Stato del capitale al 10 lug 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Segretario
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5307786
    102622300003
    ARMITAGE, John Anthony
    Leven Cottage 91 High Street
    Great Ayton
    TS9 6NF Middlesbrough
    Cleveland
    Segretario
    Leven Cottage 91 High Street
    Great Ayton
    TS9 6NF Middlesbrough
    Cleveland
    British12424870001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    HARDING, David George
    10 Cokeham Gardens
    Sompting
    BN15 9TB Lancing
    West Sussex
    Segretario
    10 Cokeham Gardens
    Sompting
    BN15 9TB Lancing
    West Sussex
    British13078050001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Segretario
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Segretario
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    British654410001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    BONNEY, Michael George
    2 The Street
    Cherhill
    SN11 8XP Calne
    Wiltshire
    Amministratore
    2 The Street
    Cherhill
    SN11 8XP Calne
    Wiltshire
    EnglandBritish12424880001
    BRADLEY, Pauline Anne
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    Amministratore
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    British34265760001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    GOULD, Jeffery Norman
    32 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    Amministratore
    32 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    British69276590001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Amministratore
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    United KingdomBritish654410001
    TANDY, Didier Michel
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    UPTON, John Edward
    Nab End Farm
    Glaisdale
    YO21 2QA Whitby
    North Yorkshire
    Amministratore
    Nab End Farm
    Glaisdale
    YO21 2QA Whitby
    North Yorkshire
    British13350940001
    WATTS, Alan Martin
    20 Clareville Street
    SW7 5AW London
    Amministratore
    20 Clareville Street
    SW7 5AW London
    British55440160001
    WHITTINGTON, Christopher Mark John
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    Amministratore
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    United KingdomBritish1140780001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Chi sono le persone con controllo significativo di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 apr 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4045874
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 mar 2012
    Consegnato il 30 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Part of phase 2 business innovation centre innova science park enfield t/no AGL139495 land at innova park enfield t/no AGL139495 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 30 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 11 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 24 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as southern city (project managment) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 4/6 bridge street congleton t/n CH313883, fixed charge all buildings and other structures, fixed charge any goodwill, fixed charge all plant machinery and other items, assigns rental income, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 feb 1996
    Consegnato il 20 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    F/H-land and buildings on the north side of london road grays t/n-EX28207. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1992
    Consegnato il 24 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1, 1A and 3A gas road, pontypridd, mid glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1991
    Consegnato il 24 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £210,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H land k/a 3 market walk, hudders field, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • National & Provincial Building Society
    Transazioni
    • 24 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1991
    Consegnato il 27 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £190,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H 4 and 6 bridge street congleton, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • National & Provincial Building Society
    Transazioni
    • 27 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of off set
    Creato il 08 gen 1991
    Consegnato il 24 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the e & p finance limited and/or S.C.D.O. limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of southern, city (project management) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1990
    Consegnato il 05 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of temperance place, taff street, pontypridd, mid glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1990
    Consegnato il 05 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2, gas road, pontypridd, taff-ely, mid. Glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1990
    Consegnato il 28 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £507,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H land with the buildings erected thereon or on some part thereof & k/a 56, 57 & 58 taff street, pontypridd taff-ely district mid-glamorgan title no wa 390110.
    Persone aventi diritto
    • National & Provincial Building Society
    Transazioni
    • 28 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 18 apr 1990
    Consegnato il 01 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from brittains of rotherham limited brittain bros. (Rotherham) limited mckenna & brown (photo H1-F1) limited, mckenna & BRO5N limited southern city group limited southern & city developments limited, e, upton & sons PLC upton & southern holdings PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All sums which are now a which may at any time be at the credit of any account(s) in the books of the bank in the name of the company. (See from 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 apr 1990
    Consegnato il 01 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1988
    Consegnato il 15 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 17, 19 & 19A high street walton on thames title no. Sy 3168.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1987
    Consegnato il 17 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 56,57 and 58 taff street pontypridd mid glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 set 1987Registrazione di un'ipoteca

    D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 apr 2018Inizio della liquidazione
    14 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0