D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01570577 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Duff & Phelps Ltd The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VALAD (ENFIELD) LIMITED | 18 set 2007 | 18 set 2007 |
| SDG (ENFIELD) LIMITED | 26 mar 2004 | 26 mar 2004 |
| SCARBOROUGH DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED | 22 ago 2000 | 22 ago 2000 |
| TEESLAND DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED | 29 set 1999 | 29 set 1999 |
| SCARBOROUGH PROPERTY COMPANY (ESSEX) LIMITED | 01 apr 1996 | 01 apr 1996 |
| SOUTHERN & CITY (PROJECT MANAGEMENT) LIMITED | 26 giu 1981 | 26 giu 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 20 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 11 mag 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 15 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Edward Maddy il 12 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Exchange Place 3 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| MADDY, James Edward | Amministratore | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 137459000002 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| ARMITAGE, John Anthony | Segretario | Leven Cottage 91 High Street Great Ayton TS9 6NF Middlesbrough Cleveland | British | 12424870001 | ||||||||||
| ASH, Christine Ann | Segretario | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||||||
| COOPER, Hilary Joan | Segretario | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Segretario | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
| FRASER, Leslie Murray Fraser | Segretario | 20 Franklin Street YO12 7JU Scarborough North Yorkshire | British | 53477320001 | ||||||||||
| HARDING, David George | Segretario | 10 Cokeham Gardens Sompting BN15 9TB Lancing West Sussex | British | 13078050001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Segretario | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Segretario | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| STEVEN, Ian William | Segretario | 17 Buchanan Drive Bearsden G61 2EW Glasgow | British | 654410001 | ||||||||||
| ASH, Christine Ann | Amministratore | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||||||
| BONNEY, Michael George | Amministratore | 2 The Street Cherhill SN11 8XP Calne Wiltshire | England | British | 12424880001 | |||||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Amministratore | 6 Devonshire Terrace G12 0XF Glasgow | British | 34265760001 | ||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Amministratore | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| COOPER, Hilary Joan | Amministratore | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||||||
| GOULD, Jeffery Norman | Amministratore | 32 Flask Walk Hampstead NW3 1HE London | British | 69276590001 | ||||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Amministratore | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Amministratore | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Amministratore | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| STEVEN, Ian William | Amministratore | 17 Buchanan Drive Bearsden G61 2EW Glasgow | United Kingdom | British | 654410001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Yorkshire | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Amministratore | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| UPTON, John Edward | Amministratore | Nab End Farm Glaisdale YO21 2QA Whitby North Yorkshire | British | 13350940001 | ||||||||||
| WATTS, Alan Martin | Amministratore | 20 Clareville Street SW7 5AW London | British | 55440160001 | ||||||||||
| WHITTINGTON, Christopher Mark John | Amministratore | Southwood Lodge Kingsley Place Highgate N6 5EA London | United Kingdom | British | 1140780001 | |||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Manor Court Business Park Eastfield YO11 3TU Scarborough 1st Floor, Unit 16 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 22 mar 2012 Consegnato il 30 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Part of phase 2 business innovation centre innova science park enfield t/no AGL139495 land at innova park enfield t/no AGL139495 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 28 ago 2009 Consegnato il 11 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 giu 1996 Consegnato il 24 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as southern city (project managment) limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 4/6 bridge street congleton t/n CH313883, fixed charge all buildings and other structures, fixed charge any goodwill, fixed charge all plant machinery and other items, assigns rental income, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 feb 1996 Consegnato il 20 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Brevi particolari F/H-land and buildings on the north side of london road grays t/n-EX28207. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 dic 1992 Consegnato il 24 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1, 1A and 3A gas road, pontypridd, mid glamorgan. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 ago 1991 Consegnato il 24 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £210,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H land k/a 3 market walk, hudders field, west yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 feb 1991 Consegnato il 27 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £190,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari F/H 4 and 6 bridge street congleton, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of off set | Creato il 08 gen 1991 Consegnato il 24 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the e & p finance limited and/or S.C.D.O. limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari The balances of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of southern, city (project management) limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 nov 1990 Consegnato il 05 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the east side of temperance place, taff street, pontypridd, mid glamorgan. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 nov 1990 Consegnato il 05 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 2, gas road, pontypridd, taff-ely, mid. Glamorgan. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 giu 1990 Consegnato il 28 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £507,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari F/H land with the buildings erected thereon or on some part thereof & k/a 56, 57 & 58 taff street, pontypridd taff-ely district mid-glamorgan title no wa 390110. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of offset | Creato il 18 apr 1990 Consegnato il 01 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from brittains of rotherham limited brittain bros. (Rotherham) limited mckenna & brown (photo H1-F1) limited, mckenna & BRO5N limited southern city group limited southern & city developments limited, e, upton & sons PLC upton & southern holdings PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All sums which are now a which may at any time be at the credit of any account(s) in the books of the bank in the name of the company. (See from 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 apr 1990 Consegnato il 01 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 ott 1988 Consegnato il 15 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 17, 19 & 19A high street walton on thames title no. Sy 3168. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 ago 1987 Consegnato il 17 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 56,57 and 58 taff street pontypridd mid glamorgan. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0