BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01571833
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TROLHURST LIMITED01 lug 198101 lug 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 apr 2016

    LRESSP
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 apr 2016

    LRESSP

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    2 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di Mr Andrew William Hodges come amministratore in data 30 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicola Margaret Carroll come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2016

    Stato del capitale al 05 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicola Margaret Carroll il 09 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2015

    Stato del capitale al 17 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 feb 2014

    Stato del capitale al 27 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Steven Buck come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Centrica Directors Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Nomina di Nicola Margaret Carroll come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Bateman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Segretario
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    71532760003
    HODGES, Andrew William
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3844287
    146695600001
    FREUDMANN, Anthony
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    Segretario
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    British43335320001
    WHEATLEY, Trevor Neil Pearse
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    British34588420002
    ARIF, Louise
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    Amministratore
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    British36425190002
    BASSIS, Anne Elizabeth
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    Amministratore
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    United KingdomAmerican/British112345920001
    BATEMAN, Matthew James
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish138280510002
    BOWTELL, John Paul Maurice
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    Amministratore
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    British82969690001
    BUCK, Steven John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish96292880001
    CARROLL, Nicola
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish278861170001
    COLLIER, Edward Arthur Yarlet
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    Amministratore
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    British72213650001
    CORBETT, Michael Anthony
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    British7008160003
    CORDINGLEY, Anthony Clive
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    Amministratore
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    British7008170001
    DUNN, David Young
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    Amministratore
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    British38982880001
    FARRAR, John Trueman
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    British34540860001
    FARROW, Dennis
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    Amministratore
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    British10910860001
    FLETT, Alan Douglas
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish93037840001
    HAYWARD, Ian Charles
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    British79564240001
    KENDLE, David Philip
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    Amministratore
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish95977510001
    KENYON, Rodney Frank
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    Amministratore
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    EnglandBritish62258710001
    LAIRD, James
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    British34535330001
    LENHAM, Stephen
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    Amministratore
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    British7008190004
    MAXEY, Clement Leslie
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    British37195980001
    PINCHIN, Terence Rodney
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    Amministratore
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    British65159820001
    RAY, John Albert
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish104536620001
    SHAW, Daniel Rankin
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    Amministratore
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    ScotlandBritish7008210001
    SHEARS, John Nicholas
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    BritishBritish61771310001
    STERN, Christopher John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    EnglandEnglish55825790001
    TURNER, Moira Lynne
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82549950002
    UZIELLI, Michael Robin
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    British107591700002

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 15 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 1999
    Consegnato il 30 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1999
    Consegnato il 10 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1999
    Consegnato il 10 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 05 nov 1998
    Consegnato il 14 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead
    Brevi particolari
    All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof.
    Persone aventi diritto
    • Renbrook Limited
    Transazioni
    • 14 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 ott 1996
    Consegnato il 30 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed
    Brevi particolari
    Rent deposit of £1300.
    Persone aventi diritto
    • Renbrook Limited
    Transazioni
    • 30 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 14 mar 1996
    Consegnato il 16 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creato il 17 gen 1996
    Consegnato il 23 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 23 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1995
    Consegnato il 07 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Slark Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 07 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1995
    Consegnato il 17 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1994
    Consegnato il 04 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 08 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82
    Brevi particolari
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 1986
    Consegnato il 19 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    115 marsham court marsham street london.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 gen 1982
    Consegnato il 21 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 apr 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0