CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP

CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 01580263
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP LIMITED13 dic 199413 dic 1994
    TIPHOOK PLC14 mag 198514 mag 1985
    TIPHOOK HOLDINGS LIMITED26 nov 198226 nov 1982
    PACEYARD LIMITED14 ago 198114 ago 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT a 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT

    2 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT

    2 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 13 ott 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 set 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Thomas Peter Budge come amministratore in data 11 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Akhlesh Prasad Mathur come amministratore in data 11 giu 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    24 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reg registered 16/09/2019
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Assenso alla riregistrazione

    1 pagineFOA-RR

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    37 pagineMAR

    Riregistrazione da società a responsabilità limitata privata a società a responsabilità illimitata privata

    2 pagineRR05

    Notifica di Ge Capital International Holdings Limited come persona con controllo significativo il 13 set 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Ige Usa Investments Limited come persona con controllo significativo il 13 set 2019

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Akhlesh Prasad Mathur il 01 ago 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Thomas Peter Budge il 01 ago 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Shahryar Mufti il 01 ago 2019

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomMaltese228824220001
    MUFTI, Shahryar
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish215531750001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Segretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Segretario
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Segretario
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    ANDREW, Jonathan
    The Malt House
    Grove End
    OX15 5BA Upper Brailes
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Malt House
    Grove End
    OX15 5BA Upper Brailes
    Oxfordshire
    British88713160001
    ASHTON, Richard
    Quinten Massigstraat 2-7
    FOREIGN Amsterdam
    1077mc
    The Netherlands
    Amministratore
    Quinten Massigstraat 2-7
    FOREIGN Amsterdam
    1077mc
    The Netherlands
    British74196630001
    BARNETT, Rick
    57 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    57 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British62374150002
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Amministratore
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    BRADLEY, Todd
    20336 Wallingford Lane Barrington
    Illinois 60010
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    20336 Wallingford Lane Barrington
    Illinois 60010
    FOREIGN Usa
    American55926160001
    BRAIDWOOD, Rodger Gordon
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    Amministratore
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    EnglandBritish1484600001
    BUCCI, John Vincent
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    America81623160001
    BUDGE, Andrew Thomas Peter
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Amministratore
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United KingdomBritish182363660001
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    Amministratore
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    EnglandBritish239557120001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Amministratore
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Amministratore
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Amministratore
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Amministratore
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Amministratore
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    DICK, John Kenneth
    Overbye
    Church Street
    KT11 3EG Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Overbye
    Church Street
    KT11 3EG Cobham
    Surrey
    British1484610001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Amministratore
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HAMBRO, Rupert Nicholas
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    Amministratore
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    EnglandBritish74481160001
    HODGKISS, Roger Hilton
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    Amministratore
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    United KingdomBritish76993260001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    KOHLHAUSSEN, Martin, Dr
    Am Rabenstein 7
    Bad Homburg
    Hessen 61350
    Germany
    Amministratore
    Am Rabenstein 7
    Bad Homburg
    Hessen 61350
    Germany
    German85199450001
    MATHUR, Akhlesh Prasad
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Amministratore
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United KingdomBritish199428980002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Amministratore
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OLIVER, John Lancaster
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    Amministratore
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    British87846400001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    13 set 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione9666321
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    26 lug 2017
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3255766
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    12 set 201601 dic 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 lug 1996
    Consegnato il 30 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter indemnity dated 4/10/90 and/or this charge
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter indemnity dated 17/11/88 and/or this charge
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's acount numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter-indemnity dated 18/4/90 and/or this charge
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter-indemnity dated 17/11/88 and or this charge
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 24 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a counter-indemnity dated 30TH august 1990 in respect of a guarantee dated 5TH september 1990 and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to account no: 9834362 held with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 14TH january 1991 and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653110 and 7943377. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank A.G. London Branch
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an indemnity contained in an uncommitted multiple facility agreement dated 24TH july 1991 and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account no.5487913 Including the balance standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee dated 30TH april 1992 and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653153 and 7943393. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 21 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the said agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined Therein) or the Banks (as Defined in the Credit Agreement Dated 13TH February 1994)
    Transazioni
    • 21 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 01 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 09/04/92
    Brevi particolari
    The equipment purchased as defined on form 395 ref:245.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 1988
    Consegnato il 03 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge l/h property k/a 2ND floor flat 83 widmore road bromley kent title no sgl 1 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Scotiabank (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 1988
    Consegnato il 03 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all that f/h land situate at and k/a 83 widmore road bromley kent title no K219640 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Scotiabank (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 feb 1988
    Consegnato il 25 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter date 10/2/88 and/or this charge
    Brevi particolari
    All frieght containers (the equipment) as described in the schedule to the mortgage.
    Persone aventi diritto
    • Copenhagen Handels Bank a/S
    Transazioni
    • 25 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memo. Repeat of east deposits
    Creato il 23 dic 1987
    Consegnato il 11 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The amount of us dollars 6,000,000,00 depositor with the chargee etc (see form 395 M449/jan 13/cf for details).
    Persone aventi diritto
    • Commerybank Aktingesellaschaft
    Transazioni
    • 11 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Gurantee & debenture
    Creato il 02 nov 1984
    Consegnato il 21 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 nov 1983
    Consegnato il 17 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    04 and/or tiphook container leasing co. Limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 nov 1982
    Consegnato il 05 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies or to become due from pearlbury limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/11/82
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts, uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all stocks, shars, and other securities.
    Persone aventi diritto
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transazioni
    • 05 nov 1982Registrazione di un'ipoteca

    CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 set 2020Inizio della liquidazione
    13 ott 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0