CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP
Panoramica
| Nome della società | CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 01580263 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP LIMITED | 13 dic 1994 | 13 dic 1994 |
| TIPHOOK PLC | 14 mag 1985 | 14 mag 1985 |
| TIPHOOK HOLDINGS LIMITED | 26 nov 1982 | 26 nov 1982 |
| PACEYARD LIMITED | 14 ago 1981 | 14 ago 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT a 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 13 ott 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Thomas Peter Budge come amministratore in data 11 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Akhlesh Prasad Mathur come amministratore in data 11 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 24 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Assenso alla riregistrazione | 1 pagine | FOA-RR | ||||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato | 1 pagine | CERT3 | ||||||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 37 pagine | MAR | ||||||||||||||
Riregistrazione da società a responsabilità limitata privata a società a responsabilità illimitata privata | 2 pagine | RR05 | ||||||||||||||
Notifica di Ge Capital International Holdings Limited come persona con controllo significativo il 13 set 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione di Ige Usa Investments Limited come persona con controllo significativo il 13 set 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Akhlesh Prasad Mathur il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Thomas Peter Budge il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Shahryar Mufti il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GATT, Jonathan Lawrence John | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Maltese | 228824220001 | |||||||||
| MUFTI, Shahryar | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 215531750001 | |||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Segretario | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| PRICE, Philip Ian | Segretario | 4 Queenswood Avenue Hutton CM13 1HR Brentwood Essex | British | 75578650002 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Handran | Segretario | Flat 2 19 Netherhall Gardens NW3 5RL Hampstead London | Australian | 50914130001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Segretario | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| ANDREW, Jonathan | Amministratore | The Malt House Grove End OX15 5BA Upper Brailes Oxfordshire | British | 88713160001 | ||||||||||
| ASHTON, Richard | Amministratore | Quinten Massigstraat 2-7 FOREIGN Amsterdam 1077mc The Netherlands | British | 74196630001 | ||||||||||
| BARNETT, Rick | Amministratore | 57 Stones Drive Ripponden HX6 4NY Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 62374150002 | ||||||||||
| BEADLE, Paul Laurence | Amministratore | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | United Kingdom | British | 100238650001 | |||||||||
| BRADLEY, Todd | Amministratore | 20336 Wallingford Lane Barrington Illinois 60010 FOREIGN Usa | American | 55926160001 | ||||||||||
| BRAIDWOOD, Rodger Gordon | Amministratore | Abbotsleigh Rosecroft Park Farnham Lane TN3 0DZ Langton Green Kent | England | British | 1484600001 | |||||||||
| BUCCI, John Vincent | Amministratore | Summerhill Steels Lane, Oxshott KT22 0QQ Leatherhead Surrey | America | 81623160001 | ||||||||||
| BUDGE, Andrew Thomas Peter | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire | United Kingdom | British | 182363660001 | |||||||||
| BURNS, Bernard Kenneth Robbie | Amministratore | Church Barn House Church End MK40 4AS Biddenham Bedfordshire | England | British | 239557120001 | |||||||||
| CAKEBREAD, David | Amministratore | The Quadrant Aztec West BS32 4GQ Bristol 2630 United Kingdom | United Kingdom | British | 183172770001 | |||||||||
| CHANDLER, Andrew Philip | Amministratore | 66 Baywell Leybourne ME19 5QQ West Malling Kent | British | 53832740001 | ||||||||||
| CITRON, Zachary Joseph | Amministratore | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | 91783950001 | ||||||||||
| CLARK, Roy Graham | Amministratore | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | 65257100001 | ||||||||||
| CLUBB, Ian Mcmaster | Amministratore | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | 3485960001 | ||||||||||
| CROWTHER, Jonathan Michael | Amministratore | 11 Wheatley Rise LS29 8SQ Ilkley West Yorkshire | England | British | 49068160001 | |||||||||
| DICK, John Kenneth | Amministratore | Overbye Church Street KT11 3EG Cobham Surrey | British | 1484610001 | ||||||||||
| GOODWIN, Eric | Amministratore | Brewers Wood Pondfield Lane Shorne DA12 3LD Gravesend Kent | England | British | 45623310001 | |||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Amministratore | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| HAMBRO, Rupert Nicholas | Amministratore | 186 Ebury Street SW1W 8UP London | England | British | 74481160001 | |||||||||
| HODGKISS, Roger Hilton | Amministratore | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | United Kingdom | British | 76993260001 | |||||||||
| HOWELL, David | Amministratore | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | 109591300001 | |||||||||
| KOHLHAUSSEN, Martin, Dr | Amministratore | Am Rabenstein 7 Bad Homburg Hessen 61350 Germany | German | 85199450001 | ||||||||||
| MATHUR, Akhlesh Prasad | Amministratore | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire | United Kingdom | British | 199428980002 | |||||||||
| MONTAGUE, Robert Joel | Amministratore | Pusey House SN7 8QB Pusey Oxfordshire | British | 65130630002 | ||||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Amministratore | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | 87846400001 | ||||||||||
| PALMER, Christopher Antony | Amministratore | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | 4764800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Capital International Holdings Limited | 13 set 2019 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Ige Usa Investments Limited | 26 lug 2017 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 12 set 2016 | 01 dic 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 26 lug 1996 Consegnato il 30 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter indemnity dated 4/10/90 and/or this charge | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter indemnity dated 17/11/88 and/or this charge | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the company's acount numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter-indemnity dated 18/4/90 and/or this charge | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter-indemnity dated 17/11/88 and or this charge | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 24 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a counter-indemnity dated 30TH august 1990 in respect of a guarantee dated 5TH september 1990 and this deed (as defined therein) | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to account no: 9834362 held with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 23 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 14TH january 1991 and this deed (as defined therein) | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653110 and 7943377. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 23 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an indemnity contained in an uncommitted multiple facility agreement dated 24TH july 1991 and this deed (as defined therein) | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the company's account no.5487913 Including the balance standing to the credit of the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 23 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee dated 30TH april 1992 and this deed (as defined therein) | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653153 and 7943393. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 mar 1994 Consegnato il 21 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the said agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 01 mag 1992 Consegnato il 22 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 09/04/92 | |
Brevi particolari The equipment purchased as defined on form 395 ref:245. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 ott 1988 Consegnato il 03 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge l/h property k/a 2ND floor flat 83 widmore road bromley kent title no sgl 1 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 ott 1988 Consegnato il 03 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed charge all that f/h land situate at and k/a 83 widmore road bromley kent title no K219640 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 feb 1988 Consegnato il 25 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter date 10/2/88 and/or this charge | |
Brevi particolari All frieght containers (the equipment) as described in the schedule to the mortgage. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memo. Repeat of east deposits | Creato il 23 dic 1987 Consegnato il 11 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The amount of us dollars 6,000,000,00 depositor with the chargee etc (see form 395 M449/jan 13/cf for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Gurantee & debenture | Creato il 02 nov 1984 Consegnato il 21 nov 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 08 nov 1983 Consegnato il 17 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 04 and/or tiphook container leasing co. Limited | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 nov 1982 Consegnato il 05 nov 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies or to become due from pearlbury limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/11/82 | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts, uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all stocks, shars, and other securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0