ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED

ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàING LEASE FLEET FINANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01582263
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    • (6521) /

    Dove si trova ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ING FLEET FINANCE LIMITED08 nov 200108 nov 2001
    DRKW FLEET FINANCE LIMITED23 apr 200123 apr 2001
    KLEINWORT BENSON FLEET FINANCE LIMITED16 giu 198616 giu 1986
    KLEINWORT, BENSON FLEET FINANCE LIMITED25 ago 198325 ago 1983
    HIGHWAY FINANCE LIMITED15 feb 198215 feb 1982
    RIVERSTAR FINANCE LIMITED24 ago 198124 ago 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 gen 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2010

    Stato del capitale al 07 apr 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Paul Stamper il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per William Llewelyn Lewis il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Harris il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Daniel Nicholas Owen Francis il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per William Llewelyn Lewis il 14 gen 2010

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 gen 2009

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 gen 2008

    4 pagineAA

    Bilancio redatto al 01 gen 2007

    14 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    16 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, William Llewelyn, Mrewelyn
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Segretario
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    British12939250003
    FRANCIS, Daniel Nicholas Owen
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    United KingdomBritish108324490003
    HARRIS, Robert
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    United KingdomBritish83818910001
    LEWIS, William Llewelyn, Mrewelyn
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    EnglandBritish12939250003
    STAMPER, Christopher Paul
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1NY Surrey
    EnglandBritish37053220002
    AMEY, Michelle
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    Segretario
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    British57746950002
    LONGCROFT, Peter Leonard
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    Segretario
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    British32431030003
    MORRISON, Audrey
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    Segretario
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    British44972470001
    SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    British110050670001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Segretario
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    British45988970001
    YUE, Frederick
    25 Regent Road
    KT5 8NN Surbiton
    Surrey
    Segretario
    25 Regent Road
    KT5 8NN Surbiton
    Surrey
    British13202680002
    BAIRD, John David Lowis
    67 Onslow Road
    TW10 6QA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    67 Onslow Road
    TW10 6QA Richmond
    Surrey
    British13191220001
    BARTLEY, Paul Robert Matthew
    Buckleswood
    East Grinstead Road
    BN8 4JA North Chailey
    East Sussex
    Amministratore
    Buckleswood
    East Grinstead Road
    BN8 4JA North Chailey
    East Sussex
    British54107140001
    CAMERON, Christopher Andrew
    The Bothy And Forge
    Ightham Court
    TN15 9JF Ightham
    Kent
    Amministratore
    The Bothy And Forge
    Ightham Court
    TN15 9JF Ightham
    Kent
    British14446740001
    CUREL, Bryan William
    20 Brampton Chase Northfield Avenue
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    20 Brampton Chase Northfield Avenue
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    British47377500001
    CUREL, Bryan William
    20 Brampton Chase Northfield Avenue
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    20 Brampton Chase Northfield Avenue
    Lower Shiplake
    RG9 3BX Henley On Thames
    Oxfordshire
    British47377500001
    DERBY, Philip
    Dorchester House
    13 Holmes Close Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Dorchester House
    13 Holmes Close Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    British54892990006
    DIGWEED, Philip John
    5 Brampton Bank
    Tudeley
    TN11 0PN Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    5 Brampton Bank
    Tudeley
    TN11 0PN Tonbridge
    Kent
    British76382240001
    DRAMBY, Thomas George
    22 Cliddesden Court
    RG21 3ES Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    22 Cliddesden Court
    RG21 3ES Basingstoke
    Hampshire
    EnglandAmerican125821650001
    FARLEY, Oliver Mario Josef
    White Cottage 10 Denne Road
    RH12 1JF Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    White Cottage 10 Denne Road
    RH12 1JF Horsham
    West Sussex
    British13013290001
    FORREST, Michael Roger
    70 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UP Bristol
    Avon
    Amministratore
    70 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UP Bristol
    Avon
    EnglandBritish13129220001
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Amministratore
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    JOHNSTON, Anthony Maurice
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    Amministratore
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    EnglandBritish91243020001
    MCCOMB, Robert Wilson
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    Amministratore
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    United KingdomBritish13929280001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish7680750001
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    1 Windermere Road
    Ealing
    W5 4TJ London
    Amministratore
    1 Windermere Road
    Ealing
    W5 4TJ London
    Irish56976610001
    SMITH, Jacqueline June, Mrs.
    Brook House 21 South Lea Road
    Datchet
    SL3 9BY Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Brook House 21 South Lea Road
    Datchet
    SL3 9BY Slough
    Berkshire
    EnglandBritish13326950001
    STALKER, Christopher David
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    EngalndBritish75389440001
    VOSS, David Anthony Henry
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British6551300002
    WEBSTER, Andrew Edward Christopher
    Fig Lodge
    Cheriton Road
    SO22 5AX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Fig Lodge
    Cheriton Road
    SO22 5AX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish227539080001
    WHITE, Andrew John
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    British8107360001
    WILLIAMS, William Guy
    39 The Conifers
    RG45 6TG Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    39 The Conifers
    RG45 6TG Crowthorne
    Berkshire
    British69333500001
    YUE, Frederick
    25 Regent Road
    KT5 8NN Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    25 Regent Road
    KT5 8NN Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish13202680002

    ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Statutory mortgage
    Creato il 28 mar 1985
    Consegnato il 04 apr 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on a account current under the terms of a deed of covenant dated 28TH march 1985 pursuant to a indemnity and security dated 28TH march 1985
    Brevi particolari
    32/64TH shares in the vessel "petersfield" and in her boats and appurtenances, of which the company are the owners.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank
    Transazioni
    • 04 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenants
    Creato il 28 mar 1985
    Consegnato il 04 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28TH march 1985 pursuant to an indemnity and security agreement dated 28TH march 1985
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest in and to the vessel "petersfield".
    Persone aventi diritto
    • Chemical Bank
    Transazioni
    • 04 apr 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0