ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01582263 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
- (6521) /
Dove si trova ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ING FLEET FINANCE LIMITED | 08 nov 2001 | 08 nov 2001 |
| DRKW FLEET FINANCE LIMITED | 23 apr 2001 | 23 apr 2001 |
| KLEINWORT BENSON FLEET FINANCE LIMITED | 16 giu 1986 | 16 giu 1986 |
| KLEINWORT, BENSON FLEET FINANCE LIMITED | 25 ago 1983 | 25 ago 1983 |
| HIGHWAY FINANCE LIMITED | 15 feb 1982 | 15 feb 1982 |
| RIVERSTAR FINANCE LIMITED | 24 ago 1981 | 24 ago 1981 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 01 gen 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Paul Stamper il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per William Llewelyn Lewis il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Robert Harris il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Daniel Nicholas Owen Francis il 14 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per William Llewelyn Lewis il 14 gen 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 gen 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 gen 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 gen 2007 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 8 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2005 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2004 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 8 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2003 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, William Llewelyn, Mrewelyn | Segretario | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey | British | 12939250003 | ||||||
| FRANCIS, Daniel Nicholas Owen | Amministratore | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey | United Kingdom | British | 108324490003 | |||||
| HARRIS, Robert | Amministratore | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey | United Kingdom | British | 83818910001 | |||||
| LEWIS, William Llewelyn, Mrewelyn | Amministratore | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey | England | British | 12939250003 | |||||
| STAMPER, Christopher Paul | Amministratore | 60 High Street Redhill RH1 1NY Surrey | England | British | 37053220002 | |||||
| AMEY, Michelle | Segretario | 4 Holme Road RM11 3QS Hornchurch Essex | British | 57746950002 | ||||||
| LONGCROFT, Peter Leonard | Segretario | 4 Lakeside Close Reydon IP18 6YA Southwold Suffolk | British | 32431030003 | ||||||
| MORRISON, Audrey | Segretario | 20 Bliss Avenue SG17 5SF Shefford Bedfordshire | British | 44972470001 | ||||||
| SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane | Segretario | Oliver House Stud Ched Glow SN16 9EZ Malmesbury Wiltshire | British | 110050670001 | ||||||
| YOUNG, Lorraine Elizabeth | Segretario | 3 Vaughan Avenue TN10 4EB Tonbridge Kent | British | 45988970001 | ||||||
| YUE, Frederick | Segretario | 25 Regent Road KT5 8NN Surbiton Surrey | British | 13202680002 | ||||||
| BAIRD, John David Lowis | Amministratore | 67 Onslow Road TW10 6QA Richmond Surrey | British | 13191220001 | ||||||
| BARTLEY, Paul Robert Matthew | Amministratore | Buckleswood East Grinstead Road BN8 4JA North Chailey East Sussex | British | 54107140001 | ||||||
| CAMERON, Christopher Andrew | Amministratore | The Bothy And Forge Ightham Court TN15 9JF Ightham Kent | British | 14446740001 | ||||||
| CUREL, Bryan William | Amministratore | 20 Brampton Chase Northfield Avenue Lower Shiplake RG9 3BX Henley On Thames Oxfordshire | British | 47377500001 | ||||||
| CUREL, Bryan William | Amministratore | 20 Brampton Chase Northfield Avenue Lower Shiplake RG9 3BX Henley On Thames Oxfordshire | British | 47377500001 | ||||||
| DERBY, Philip | Amministratore | Dorchester House 13 Holmes Close Sunninghill SL5 9TJ Ascot Berkshire | British | 54892990006 | ||||||
| DIGWEED, Philip John | Amministratore | 5 Brampton Bank Tudeley TN11 0PN Tonbridge Kent | British | 76382240001 | ||||||
| DRAMBY, Thomas George | Amministratore | 22 Cliddesden Court RG21 3ES Basingstoke Hampshire | England | American | 125821650001 | |||||
| FARLEY, Oliver Mario Josef | Amministratore | White Cottage 10 Denne Road RH12 1JF Horsham West Sussex | British | 13013290001 | ||||||
| FORREST, Michael Roger | Amministratore | 70 Upper Cranbrook Road Westbury Park BS6 7UP Bristol Avon | England | British | 13129220001 | |||||
| JACK, Stephen Andrew | Amministratore | 1 Hunter Road West Wimbledon SW20 8NZ London | England | British | 13013280001 | |||||
| JOHNSTON, Anthony Maurice | Amministratore | 14 Agars Place Datchet SL3 9AH Berkshire | England | British | 91243020001 | |||||
| MCCOMB, Robert Wilson | Amministratore | 3 Firs Avenue Muswell Hill N10 3LY London | United Kingdom | British | 13929280001 | |||||
| MORROW, John David | Amministratore | 281 Greys Road RG9 1QT Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 7680750001 | |||||
| O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas | Amministratore | 1 Windermere Road Ealing W5 4TJ London | Irish | 56976610001 | ||||||
| SMITH, Jacqueline June, Mrs. | Amministratore | Brook House 21 South Lea Road Datchet SL3 9BY Slough Berkshire | England | British | 13326950001 | |||||
| STALKER, Christopher David | Amministratore | Nightingale Cottage 4 Popes Lane SL6 9NY Cookham Dean Berkshire | Engalnd | British | 75389440001 | |||||
| VOSS, David Anthony Henry | Amministratore | Calleva Harpsden Way RG9 1NL Henley On Thames Oxfordshire | British | 6551300002 | ||||||
| WEBSTER, Andrew Edward Christopher | Amministratore | Fig Lodge Cheriton Road SO22 5AX Winchester Hampshire | England | British | 227539080001 | |||||
| WHITE, Andrew John | Amministratore | White Timbers Ewhurst Green Ewhurst GU6 7SF Cranleigh Surrey | British | 8107360001 | ||||||
| WILLIAMS, William Guy | Amministratore | 39 The Conifers RG45 6TG Crowthorne Berkshire | British | 69333500001 | ||||||
| YUE, Frederick | Amministratore | 25 Regent Road KT5 8NN Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 13202680002 |
ING LEASE FLEET FINANCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Statutory mortgage | Creato il 28 mar 1985 Consegnato il 04 apr 1985 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on a account current under the terms of a deed of covenant dated 28TH march 1985 pursuant to a indemnity and security dated 28TH march 1985 | |
Brevi particolari 32/64TH shares in the vessel "petersfield" and in her boats and appurtenances, of which the company are the owners. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenants | Creato il 28 mar 1985 Consegnato il 04 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28TH march 1985 pursuant to an indemnity and security agreement dated 28TH march 1985 | |
Brevi particolari All the company's right, title and interest in and to the vessel "petersfield". | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0