MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED

MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCNAUGHTON PRINTALL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01595002
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRINTALL DISPLAY LTD.07 lug 198907 lug 1989
    PRINTALL DISPLAY MATERIALS LIMITED26 gen 198226 gen 1982
    HUNTSTRADE LIMITED02 nov 198102 nov 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Ian Anthony George come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2012

    Stato del capitale al 22 feb 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Memorandum e Statuto

    30 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Anthony George il 01 nov 2011

    3 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Anthony George il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Alistair Robert Wade il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Anthony George il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Penrigh il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Nomina di Abogado Nominees Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da Jaymac House Church Manorway Erith Kent DA8 1DF in data 24 mag 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Ian Pinks come segretario

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Segretario
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1688036
    73539350001
    PENRIGH, Andrew
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    Bardon Hill
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    Amministratore
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    Bardon Hill
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    British101173400001
    WADE, Alistair Robert
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    Bardon Hill
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    Amministratore
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    Bardon Hill
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    British60758370001
    CHAKRAVARTY, Saroj Kanti
    55 The Avenue
    BR3 2EE Beckenham
    Kent
    Segretario
    55 The Avenue
    BR3 2EE Beckenham
    Kent
    British8681900001
    CROUCH, Keith Arthur
    67 College Road
    Hextable
    BR8 7LW Swanley
    Kent
    Segretario
    67 College Road
    Hextable
    BR8 7LW Swanley
    Kent
    British43496750001
    PINKS, Ian Peter
    Barn Hill
    Hunton
    ME15 0QT Maidstone
    Barn Hill House
    Kent
    Segretario
    Barn Hill
    Hunton
    ME15 0QT Maidstone
    Barn Hill House
    Kent
    British13581570003
    BARRETT, Nigel Howard Stuart
    Forest View Dockenfield
    GU10 4HA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Forest View Dockenfield
    GU10 4HA Farnham
    Surrey
    British14928060001
    CLARK, Christopher Anthony Peter
    14 Studley Court
    Studley Drive
    IG4 5AL Ilford
    Essex
    Amministratore
    14 Studley Court
    Studley Drive
    IG4 5AL Ilford
    Essex
    British55300390002
    FENAROLI, Edward John
    56 Blakes Avenue
    KT3 6RF New Malden
    Surrey
    Amministratore
    56 Blakes Avenue
    KT3 6RF New Malden
    Surrey
    Italian8681910001
    GEORGE, Ian Anthony
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    Amministratore
    c/o Antalis Mcnaughton Limited
    Interlink Way West
    LE67 1LE Coalville
    Gateway House
    Leicestershire
    United KingdomBritish8681920005
    GIBSON, Philippe
    Comp Lodge Comp Lane
    St Marys Platt
    TN15 8QS Borough Green
    Kent
    Amministratore
    Comp Lodge Comp Lane
    St Marys Platt
    TN15 8QS Borough Green
    Kent
    EnglandBritish161666780001
    HOLLINS, Robert Ian Wettenham
    15 Heath Gardens
    TW1 4LY Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    15 Heath Gardens
    TW1 4LY Twickenham
    Middlesex
    British14928100001
    SIMPSON, Julian Charles
    Shilling Cottage
    Avington
    SO21 1DD Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Shilling Cottage
    Avington
    SO21 1DD Winchester
    Hampshire
    British70842400002
    SIMPSON, Nicholas Mark
    Watercress Cottage
    62 The Butts
    GU34 1RD Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Watercress Cottage
    62 The Butts
    GU34 1RD Alton
    Hampshire
    British14928080002
    TRUMPER, John Richard Walwyn
    Rumbow Cottage
    Howe Green Howe
    CR5 Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Rumbow Cottage
    Howe Green Howe
    CR5 Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish10338290001

    MCNAUGHTON PRINTALL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture containing fixed and floating charge
    Creato il 18 set 1991
    Consegnato il 25 set 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel Bank A.G.
    Transazioni
    • 25 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture containing fixed and floating charge
    Creato il 18 set 1991
    Consegnato il 25 set 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel Bank A.G.
    Transazioni
    • 25 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 03 feb 1989
    Consegnato il 18 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 3/2/87 or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Century Factors Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 1988
    Consegnato il 24 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 3/2/87 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Century Factors Limited
    Transazioni
    • 24 nov 1988Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0