ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED

ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01596444
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Triton Street
    NW1 3BF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ULTIMATE OFFICE EQUIPMENT LIMITED08 gen 198208 gen 1982
    SIGNWEDGE LIMITED09 nov 198109 nov 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 mar 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 66 Chiltern Street London W1U 4AG in data 09 dic 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Nicola Clare Downing come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter Simpson come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2010

    Stato del capitale al 23 giu 2010

    • Capitale: GBP 45,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ikon House 30 Cowcross Street London EC1M 6DQ in data 11 nov 2009

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2004

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2003

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOWNING, Nicola Clare
    Chiltern Street
    W1U 4AG London
    66
    United Kingdom
    Segretario
    Chiltern Street
    W1U 4AG London
    66
    United Kingdom
    British155544880001
    MILLS, David
    Fourfields
    Uvedale Road
    RH8 0EW Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Fourfields
    Uvedale Road
    RH8 0EW Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish72326700001
    PRASTKA, Christopher Richard
    Cedars 26 Portman Park
    TN9 1LW Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Cedars 26 Portman Park
    TN9 1LW Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish38634910001
    DOBSON, Isabel Claire
    10 Stockfield Road
    SW16 2LR London
    Segretario
    10 Stockfield Road
    SW16 2LR London
    British66065060001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    British78519720002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Segretario
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    British15201600002
    SIMPSON, Peter John
    Gleniffer
    2 Elizabethan Way Maidenbower
    RH10 7GU Crawley
    West Sussex
    Segretario
    Gleniffer
    2 Elizabethan Way Maidenbower
    RH10 7GU Crawley
    West Sussex
    British712540001
    BALDWIN, Alan Peter
    Field House
    Churt
    GU10 2QE Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Field House
    Churt
    GU10 2QE Farnham
    Surrey
    British56675660001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish78519720002
    DUNCKLEY, Peter John
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    EnglandBritish1173580001
    EBSWORTH, Anthony John
    Chippenham Hill
    Moulton
    CB8 7PL Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Chippenham Hill
    Moulton
    CB8 7PL Newmarket
    Suffolk
    United KingdomBritish37469830001
    FRANCIS, Kevin Nicolas
    Woodlands
    83 Fakenham Road
    NR9 5AE Great Witchingham
    Norfolk
    Amministratore
    Woodlands
    83 Fakenham Road
    NR9 5AE Great Witchingham
    Norfolk
    EnglandBritish93924330001
    MODEN, Kevin
    41 West Road
    IP33 3EN Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    41 West Road
    IP33 3EN Bury St Edmunds
    Suffolk
    British11609010001
    ROBERJOT, Paul Anthony
    The Gallops
    Middleton Common Road Westmeston
    BN6 8SF Hassocks
    West Sussex
    Amministratore
    The Gallops
    Middleton Common Road Westmeston
    BN6 8SF Hassocks
    West Sussex
    British10397700001
    WRIGHT, Edward William
    36 Martingale Drive
    CM1 6FN Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    36 Martingale Drive
    CM1 6FN Chelmsford
    Essex
    British53271550001

    ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1995
    Consegnato il 14 ott 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a ultimate house eastern way bury st edmunds suffolk. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 21 giu 1995
    Consegnato il 28 giu 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 10 mar 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Security Trustee for the Lendes)
    Transazioni
    • 10 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of maintenance agreements
    Creato il 05 ago 1994
    Consegnato il 26 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title & benefit under or in the contracts, all guarantees & sureties or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 lug 1994
    Consegnato il 19 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit D10,pinetrees rd,sprowston,broadland,norfolk; t/no.nk 82274.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 04 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situate at eastern way bury st edmunds suffolk having a frontage of twenty feet to eastern way.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1993
    Consegnato il 23 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 10,pinetrees business park,norwich,norfolk. T/n NK68776.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1990
    Consegnato il 21 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 set 1990
    Consegnato il 18 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ultimate house eastern way industrial estate bury st edmunds suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 apr 1989
    Consegnato il 28 apr 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit D10 pinetrees business park, salhouse road, sprowston norfolk. Proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 24 gen 1985
    Consegnato il 30 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specfic equitable charge over all f/h & l/h properties and proceeds of sale thereof fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future goodwill including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1985Registrazione di un'ipoteca

    ULTIMATE GROUP HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 gen 2012Data di scioglimento
    10 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Praticante
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Praticante
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0