TELEFLEX UK LIMITED

TELEFLEX UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELEFLEX UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01600496
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELEFLEX UK LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova TELEFLEX UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teleflex Medical Uk
    Stirling Road
    HP12 3ST Cressex Business Park
    High Wycombe
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TELEFLEX UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMO INDUSTRIES (UK) LIMITED22 dic 198922 dic 1989
    BAIRD U.K. HOLDINGS LIMITED17 mar 198217 mar 1982
    TOUCHVALE LIMITED27 nov 198127 nov 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELEFLEX UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per TELEFLEX UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 ott 2009

    • Capitale: GBP 1
    1 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di TELEFLEX UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Segretario
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Irish127397580001
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Amministratore
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish127397580001
    WILLIAMS, Charles Edward
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    Amministratore
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    United StatesAmerican122869170001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Segretario
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Segretario
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Segretario
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    HARRISON, Brian
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    Segretario
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    British13648350001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Segretario
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Segretario
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    British71945940002
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Segretario
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001
    STREETER, Andrew Charles
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    Segretario
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    British69339090001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    British116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Amministratore
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Amministratore
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    British76507470001
    BRADLEY, George Edward William
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    Amministratore
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    American76157540001
    BUSHELL, Anthony Thomas
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    British69190050001
    CARROLL, Leffert
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Amministratore
    588 Conroy Avenue
    Toms River
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    American18905150001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Amministratore
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    DAWSON-GOODEY, Andrew John
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    British56963660001
    DERR LL, Robert
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    Amministratore
    23
    Independence Way
    08560 Titusville
    New Jersey
    Usa
    Usa47901970001
    GILL, John George
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    British58095740001
    GREEN, Raymond Charles
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    British27243660001
    HALL, Allan Robert Macalister
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    British68216820001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    British62562220002
    KING, Ian Robert
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish103274150002
    LAW, Michael Barry
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    Amministratore
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    British95044260001
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Amministratore
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    French122049100001
    LEWIS, Brian
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    British18905160001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Amministratore
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritish71945940002
    MCCANN, Terence Michael Paul
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    British61786230001
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Amministratore
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    British103274200001

    TELEFLEX UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Equitable share charge
    Creato il 29 apr 1996
    Consegnato il 03 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement or any other loan document (as defined) and all of the obligations (as defined in the credit agreement) under the credit agreement and the other loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    (I) 2678,576 shares of £1 each in the capital of imo industries limited and (ii) 683,234 £1 shares each and 733,280 deferred £1 shares in the capital of morse controls limited; all other dividends/other income payable and all shares/other property from securities; all other rights,benefits,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Usa,Inc.
    Transazioni
    • 03 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable share charge
    Creato il 16 nov 1994
    Consegnato il 28 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due from the borrower (as defined) to the chargee under or pursuant to the credit agreement dated 5TH august 1994 (as defined) and any other loan document (as defined)
    Brevi particolari
    All securities,dividends and other income payable; all shares or other property; all other rights,benefits......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank,N.a,as Agent for Itself,the Lenders and the Issuing Banks
    Transazioni
    • 28 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 set 1993
    Consegnato il 09 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0