AGAR SCIENTIFIC LIMITED

AGAR SCIENTIFIC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAGAR SCIENTIFIC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01601520
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Elektron Technology Plc Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AGAR AIDS LIMITED02 dic 198102 dic 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 26 ott 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Lynne Joyce come amministratore in data 23 ott 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Keith Anthony Daley come amministratore in data 23 ott 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Noah Felix Kalman Franklin come amministratore in data 23 ott 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Roger Mccoy come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Lakeside Business Park Swan Lane, Sandhurst Berkshire GU47 9DN in data 01 nov 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Noah Felix Kalman Franklin come amministratore in data 31 ago 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Spink come amministratore in data 31 ago 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Cessazione della carica di Alan Cattley come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 gen 2011

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Roger Mccoy come amministratore

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Cessazione della carica di Stephen Woodland come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Martin Leslie Reeves come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Geoffrey Spink come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di AGAR SCIENTIFIC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REEVES, Martin Leslie
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    Segretario
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    154220970001
    DALEY, Keith Anthony
    Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    76
    United Kingdom
    Amministratore
    Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    76
    United Kingdom
    EnglandBritish1693740001
    ANDERSON, Brian Anthony
    South Barn, Church Farm
    Chartway Street
    ME17 3JB East Sutton
    Kent
    Segretario
    South Barn, Church Farm
    Chartway Street
    ME17 3JB East Sutton
    Kent
    British73810930002
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Segretario
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    British5333430001
    DOW, Nicoll Lany
    275 King Henrys Drive
    CR0 0AE Croydon
    Segretario
    275 King Henrys Drive
    CR0 0AE Croydon
    British79187350001
    DYER BARTLETT, Dudley Richard Max
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    Segretario
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    British71979860001
    DYER BARTLETT, Dudley Richard Max
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    Segretario
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    British71979860001
    PORTER, Robert Charles
    29 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Segretario
    29 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    British111738830001
    SHELDON, Ann Louise
    2 Andersons Way
    IP12 4EB Woodbridge
    Suffolk
    Segretario
    2 Andersons Way
    IP12 4EB Woodbridge
    Suffolk
    British65429390001
    SHELDON, Diana Mary
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    Segretario
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    British13599980001
    SPINK, Geoffrey
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    Segretario
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    British84940730001
    CATTLEY, Alan
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    Amministratore
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    EnglandBritish13657810001
    CULSHAW, Alasdair Douglas
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    Amministratore
    20 Old Malt Way
    Horsell
    GU21 4QD Woking
    Surrey
    British5333430001
    DYER BARTLETT, Dudley Richard Max
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    Amministratore
    Ketton House
    Rectory Road
    CB9 7QL Kedington
    Suffolk
    EnglandBritish71979860001
    FRANKLIN, Noah Felix Kalman
    c/o Elektron Technology Plc
    21, J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    Broers Building
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Elektron Technology Plc
    21, J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    Broers Building
    United Kingdom
    EnglandBritish53608960001
    HOLLAND, Peter
    Baileys
    Wicken Road, Arkesden
    CB11 4EY Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Baileys
    Wicken Road, Arkesden
    CB11 4EY Saffron Walden
    Essex
    British13657820002
    JOYCE, Lynne
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    Amministratore
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    United KingdomBritish13657800001
    LEEMING, David Roger
    113 Calabria Road
    N5 1HS London
    Amministratore
    113 Calabria Road
    N5 1HS London
    EnglandBritish412880001
    MCCOY, Roger
    Agnes Silverside Close
    C02 8WN Colchester
    14
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    Agnes Silverside Close
    C02 8WN Colchester
    14
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish156506870001
    NEAL, Nathan John, Mr.
    22 Chapel St
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DQ Haverhill
    Suffolk
    Amministratore
    22 Chapel St
    Steeple Bumpstead
    CB9 7DQ Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritish191426980001
    PORTER, Robert Charles
    29 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Amministratore
    29 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    EnglandBritish111738830001
    SHELDON, Ann Louise
    2 Andersons Way
    IP12 4EB Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    2 Andersons Way
    IP12 4EB Woodbridge
    Suffolk
    British65429390001
    SHELDON, Diana Mary
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    Amministratore
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    British13599980001
    SHELDON, Frederick
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    Amministratore
    Downsillion Hawkspur Green
    Little Bardfield
    CM7 4SH Braintree
    Essex
    British13599990001
    SPINK, Geoffrey
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    Amministratore
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    United KingdomBritish84940730001
    TEE, James Richard
    Willow House
    Hill Green Clavering
    CB11 4QS Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Willow House
    Hill Green Clavering
    CB11 4QS Saffron Walden
    Essex
    British25180870002
    WHITESMITH, Howard William
    111 Station Road
    Willingham
    CB4 5HG Cambridge
    Amministratore
    111 Station Road
    Willingham
    CB4 5HG Cambridge
    British56150570001
    WOODLAND, Stephen Charles
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    Amministratore
    5 Lakeside Business Park Swan
    Lane, Sandhurst
    GU47 9DN Berkshire
    United KingdomBritish136360140001

    AGAR SCIENTIFIC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 05 mag 2004
    Consegnato il 06 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 06 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 ago 2003
    Consegnato il 02 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 21 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 03 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 07 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 apr 1989
    Consegnato il 02 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 apr 1989
    Consegnato il 02 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 66A cambridge road stanstead and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1985
    Consegnato il 27 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 66A cambridge road stanstead essex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1982
    Consegnato il 26 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & premises being 66A cambridge road stanstead essex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 apr 1982
    Consegnato il 26 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0