MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED

MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01604296
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Discovery House
    Aveling Road
    HP13 6AE High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACE FIELDWORK LIMITED20 lug 200020 lug 2000
    A.C.E. (FIELDWORK) LIMITED16 feb 198716 feb 1987
    FIELD DEPARTMENT LIMITED(THE)22 mag 198422 mag 1984
    PRICETEL LIMITED15 dic 198115 dic 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2011

    Stato del capitale al 14 apr 2011

    • Capitale: GBP 150
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 set 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 lug 2008

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2007

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 28 feb 2006

    7 pagineAA

    Varie

    Section 394
    pagineMISC

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEPBURN, Richard Alexander
    14 Beech Hill Road
    Sunningdale
    SL5 0BW Ascot
    Berkshire
    Segretario
    14 Beech Hill Road
    Sunningdale
    SL5 0BW Ascot
    Berkshire
    British87981210001
    CORNISH, Charlotte Selene Pym
    51 Halford Road
    TW10 6AW Richmond
    Surrey
    Amministratore
    51 Halford Road
    TW10 6AW Richmond
    Surrey
    EnglandBritishDirector102645580001
    HEPBURN, Richard Alexander
    14 Beech Hill Road
    Sunningdale
    SL5 0BW Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    14 Beech Hill Road
    Sunningdale
    SL5 0BW Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishDirector87981210001
    GARRAD, Lynn Patricia
    49d Camden Square
    NW1 9XA London
    Segretario
    49d Camden Square
    NW1 9XA London
    BritishCompany Secretary39074710001
    REED, Alan Michael
    5 Crescent Road
    IP15 5HW Aldeburgh
    Suffolk
    Segretario
    5 Crescent Road
    IP15 5HW Aldeburgh
    Suffolk
    British2873220003
    CLARK, Janet Irene
    98 Friars Walk
    Southgate
    N14 5LN London
    Amministratore
    98 Friars Walk
    Southgate
    N14 5LN London
    BritishFieldwork Director21971840001
    DANCE, Robert John
    Stockbridge Cottage
    Tilford Road Tilford
    GU10 2DD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Stockbridge Cottage
    Tilford Road Tilford
    GU10 2DD Farnham
    Surrey
    BritishMarket Research Consultant26769560001
    DOBSON, Gillian
    51 Briarfield Avenue
    Finchley
    N3 2LG London
    Amministratore
    51 Briarfield Avenue
    Finchley
    N3 2LG London
    BritishManaging Director46819550001
    FEATHERSTONE, Shirley Audrey
    9 Hillcrest Gardens
    KT10 0BT Esher
    Surrey
    Amministratore
    9 Hillcrest Gardens
    KT10 0BT Esher
    Surrey
    BritishField Director63050740001
    LINK, Stephen
    2 Kingsley Court
    AL7 4HZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Kingsley Court
    AL7 4HZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector Of Consumer Research114459470001
    NEMKO, Michael Terence
    11 Woodhall Avenue
    HA5 3DY Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    11 Woodhall Avenue
    HA5 3DY Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant7962250001
    REED, Alan Michael
    5 Crescent Road
    IP15 5HW Aldeburgh
    Suffolk
    Amministratore
    5 Crescent Road
    IP15 5HW Aldeburgh
    Suffolk
    BritishMarket Research Consultant2873220003
    WARING, Eric John
    93c Ferme Park Road
    N8 9SA London
    Amministratore
    93c Ferme Park Road
    N8 9SA London
    United KingdomBritishIt Director97429370001
    WEITZ, Janet Ruth
    Oaklands Lime Grove
    Totteridge
    N20 8PX London
    Amministratore
    Oaklands Lime Grove
    Totteridge
    N20 8PX London
    EnglandBritishCompany Director14023340001
    WEITZ, Janet Ruth
    Oaklands Lime Grove
    Totteridge
    N20 8PX London
    Amministratore
    Oaklands Lime Grove
    Totteridge
    N20 8PX London
    EnglandBritishCompany Director14023340001

    MUNRO GLOBAL (NO.2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 14 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 gen 1999
    Consegnato il 12 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 13 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 23 feb 1993
    Consegnato il 02 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0