M.S.B. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàM.S.B. LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01605259
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di M.S.B. LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova M.S.B. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gdc First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Flintshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di M.S.B. LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per M.S.B. LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al06 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma20 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al06 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per M.S.B. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    5 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3 Forbury Place 23 Forbury Road Reading RG1 3JH England a 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Lee Auger come amministratore in data 01 dic 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di William Brownlee come amministratore in data 01 dic 2023

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    6 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Gdc First Avenue Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2NU

    1 pagineAD04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Miss Grace Mccalla come amministratore in data 28 nov 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Susan Marsden come amministratore in data 11 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Susan Marsden come segretario in data 11 nov 2022

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lisa Patricia Fishlock come amministratore in data 29 lug 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Lee Auger come amministratore in data 29 lug 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jason Conrad Brown come amministratore in data 31 gen 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Lisa Patricia Fishlock come amministratore in data 31 gen 2022

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason Conrad Brown il 19 lug 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Susan Marsden come amministratore in data 16 apr 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Susan Marsden come segretario in data 16 apr 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Clare Jane Bates come amministratore in data 16 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Clare Jane Bates come segretario in data 16 apr 2021

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di M.S.B. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWNLEE, William
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    United Kingdom
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant316751240001
    MCCALLA, Grace
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    EnglandBritishAssistant Company Secretary299226890001
    BARNES, Helen Georgina
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    British46928000001
    BATES, Clare Jane
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3 Forbury Place
    England
    Segretario
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3 Forbury Place
    England
    259338240001
    MARSDEN, Susan
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    Segretario
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    282550360001
    STAITE, Neil Anthony
    Oak Tree Cottage
    New Road Castlemorton
    WR13 6BT Malvern
    Worcs
    Segretario
    Oak Tree Cottage
    New Road Castlemorton
    WR13 6BT Malvern
    Worcs
    BritishCompany Secretary71562900005
    PRISM COSEC LIMITED
    St Georges Business Park
    207 Brooklands Road
    KT13 0TS Weybridge
    Elder House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    St Georges Business Park
    207 Brooklands Road
    KT13 0TS Weybridge
    Elder House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05533248
    116519070002
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1661542
    34893920004
    ANDERSEN, Kim
    Kettebakken 10
    Skodsborg
    2942
    Denmark
    Amministratore
    Kettebakken 10
    Skodsborg
    2942
    Denmark
    DanishChartered Accountant63540650001
    ANDREWS, Clifford John
    Newtown Road
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Brookside Cottage
    Wiltshire
    Amministratore
    Newtown Road
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Brookside Cottage
    Wiltshire
    United KingdomBritishManaging Director7617690003
    ANDREWS, Kathleen Margaret
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector154085260001
    ANDREWS, Philip James
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    BritishMarketing Director53145110001
    ANDREWS, Philip James
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Brookside Cottage
    Ramsbury
    SN8 2PP Marlborough
    Wiltshire
    BritishStudent53145110001
    AUGER, Lee
    Forbury Place
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forbury Place
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant298546960001
    BARNES, Helen Georgina
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary46928000001
    BARNES, Helen Georgina
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    BritishStudent46928000001
    BARNES, Justin David Christian
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    38 Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    Wiltshire
    BritishBusiness Development Director42044940001
    BATES, Clare Jane
    Forbury Place
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Forbury Place
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor178363560001
    BROWN, Jason Conrad
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    EnglandBritishChartered Accountant168053810002
    COTTRILL, Stephen Hedley
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Clwyd
    United Kingdom
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Clwyd
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor160001530002
    FISHLOCK, Lisa Patricia
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc First Avenue
    Flintshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc First Avenue
    Flintshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishUk&I Regional Controller292287930001
    LEWIS, Sarah Jane
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Clwyd
    United Kingdom
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Clwyd
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director134578980015
    MARSDEN, Susan
    Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3 Forbury Place
    England
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    3 Forbury Place
    England
    United KingdomBritishDeputy Company Secretary Fcis258807410001
    RONN, Lars
    Vietoften 5
    2950 Vedbaek
    Denmark
    Amministratore
    Vietoften 5
    2950 Vedbaek
    Denmark
    DanishGeneral Manager73129310001
    SEDWELL, Christopher John
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    United Kingdom
    Amministratore
    First Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NU Deeside
    Gdc
    Flintshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant290688980001
    WADE, David William
    Lychgate House
    Kings Coughton
    B49 5QF Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Lychgate House
    Kings Coughton
    B49 5QF Alcester
    Warwickshire
    BritishGeneral Manager71562540002

    Chi sono le persone con controllo significativo di M.S.B. LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Unomedical Limited
    Deeside Industrial Park
    Deeside
    CH5 2NU Flintshire
    Gdc Building First Avenue
    England And Wales
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Deeside Industrial Park
    Deeside
    CH5 2NU Flintshire
    Gdc Building First Avenue
    England And Wales
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione00976940
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    M.S.B. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 21 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 19 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H units 1,2,3,4 & 5 hilldrop lane ramsbury wiltshire-WT97071. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 19 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ago 1997
    Consegnato il 21 ago 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or first water limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1997
    Consegnato il 23 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land formerly k/a dyers yard, hilldrop lane, ramsbury wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 16 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on hilldrop lane ramesbury marlborough wiltshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £35,943.97 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this fixed charge
    Brevi particolari
    A first fixed charge over: 1 x new unilect assembly machine, serial number: 9612/2007.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 27 gen 1997
    Consegnato il 28 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £34,729 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 x new unilect assembly machine serial number: 9612/2006.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1990
    Consegnato il 17 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land formerly known as dyers yard hilldrop lane ramsbury wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counter indemnity
    Creato il 07 ott 1982
    Consegnato il 26 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    5,915,000 japanese yen standing in or to be credited to a designated account with lloyds bank PLC & all interest now due & henceforth to become due in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 07 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ago 1982
    Consegnato il 31 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery all stocks shares & other securities.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 30 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0