M.S.B. LIMITED
Panoramica
Nome della società | M.S.B. LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01605259 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di M.S.B. LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova M.S.B. LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Gdc First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Flintshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di M.S.B. LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per M.S.B. LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 06 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 20 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 06 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per M.S.B. LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 5 pagine | AA | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3 Forbury Place 23 Forbury Road Reading RG1 3JH England a 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG | 1 pagine | AD02 | ||
Cessazione della carica di Lee Auger come amministratore in data 01 dic 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di William Brownlee come amministratore in data 01 dic 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 6 pagine | AA | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Gdc First Avenue Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2NU | 1 pagine | AD04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Miss Grace Mccalla come amministratore in data 28 nov 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Susan Marsden come amministratore in data 11 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Susan Marsden come segretario in data 11 nov 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Lisa Patricia Fishlock come amministratore in data 29 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Lee Auger come amministratore in data 29 lug 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 6 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Jason Conrad Brown come amministratore in data 31 gen 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Lisa Patricia Fishlock come amministratore in data 31 gen 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason Conrad Brown il 19 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Susan Marsden come amministratore in data 16 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Susan Marsden come segretario in data 16 apr 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Clare Jane Bates come amministratore in data 16 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Clare Jane Bates come segretario in data 16 apr 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Chi sono gli amministratori di M.S.B. LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWNLEE, William | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 316751240001 | ||||||||
MCCALLA, Grace | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire | England | British | Assistant Company Secretary | 299226890001 | ||||||||
BARNES, Helen Georgina | Segretario | 38 Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough Wiltshire | British | 46928000001 | ||||||||||
BATES, Clare Jane | Segretario | 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Forbury Place England | 259338240001 | |||||||||||
MARSDEN, Susan | Segretario | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire | 282550360001 | |||||||||||
STAITE, Neil Anthony | Segretario | Oak Tree Cottage New Road Castlemorton WR13 6BT Malvern Worcs | British | Company Secretary | 71562900005 | |||||||||
PRISM COSEC LIMITED | Segretario | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
SLC REGISTRARS LIMITED | Segretario | Hersham Road KT12 1RZ Walton-On-Thames 42-50 Surrey United Kingdom |
| 34893920004 | ||||||||||
ANDERSEN, Kim | Amministratore | Kettebakken 10 Skodsborg 2942 Denmark | Danish | Chartered Accountant | 63540650001 | |||||||||
ANDREWS, Clifford John | Amministratore | Newtown Road Ramsbury SN8 2PP Marlborough Brookside Cottage Wiltshire | United Kingdom | British | Managing Director | 7617690003 | ||||||||
ANDREWS, Kathleen Margaret | Amministratore | Brookside Cottage Ramsbury SN8 2PP Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 154085260001 | ||||||||
ANDREWS, Philip James | Amministratore | Brookside Cottage Ramsbury SN8 2PP Marlborough Wiltshire | British | Marketing Director | 53145110001 | |||||||||
ANDREWS, Philip James | Amministratore | Brookside Cottage Ramsbury SN8 2PP Marlborough Wiltshire | British | Student | 53145110001 | |||||||||
AUGER, Lee | Amministratore | Forbury Place 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 298546960001 | ||||||||
BARNES, Helen Georgina | Amministratore | 38 Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough Wiltshire | British | Company Secretary | 46928000001 | |||||||||
BARNES, Helen Georgina | Amministratore | 38 Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough Wiltshire | British | Student | 46928000001 | |||||||||
BARNES, Justin David Christian | Amministratore | 38 Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough Wiltshire | British | Business Development Director | 42044940001 | |||||||||
BATES, Clare Jane | Amministratore | Forbury Place 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 178363560001 | ||||||||
BROWN, Jason Conrad | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire | England | British | Chartered Accountant | 168053810002 | ||||||||
COTTRILL, Stephen Hedley | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Clwyd United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 160001530002 | ||||||||
FISHLOCK, Lisa Patricia | Amministratore | Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc First Avenue Flintshire United Kingdom | United Kingdom | British | Uk&I Regional Controller | 292287930001 | ||||||||
LEWIS, Sarah Jane | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Clwyd United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 134578980015 | ||||||||
MARSDEN, Susan | Amministratore | Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Forbury Place England | United Kingdom | British | Deputy Company Secretary Fcis | 258807410001 | ||||||||
RONN, Lars | Amministratore | Vietoften 5 2950 Vedbaek Denmark | Danish | General Manager | 73129310001 | |||||||||
SEDWELL, Christopher John | Amministratore | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 290688980001 | ||||||||
WADE, David William | Amministratore | Lychgate House Kings Coughton B49 5QF Alcester Warwickshire | British | General Manager | 71562540002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di M.S.B. LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unomedical Limited | 06 apr 2016 | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NU Flintshire Gdc Building First Avenue England And Wales United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
M.S.B. LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 07 mag 1999 Consegnato il 21 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 mag 1999 Consegnato il 19 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H units 1,2,3,4 & 5 hilldrop lane ramsbury wiltshire-WT97071. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 06 ago 1997 Consegnato il 21 ago 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or first water limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 giu 1997 Consegnato il 23 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land formerly k/a dyers yard, hilldrop lane, ramsbury wiltshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 mag 1997 Consegnato il 16 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on hilldrop lane ramesbury marlborough wiltshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 11 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal sum of £35,943.97 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this fixed charge | |
Brevi particolari A first fixed charge over: 1 x new unilect assembly machine, serial number: 9612/2007. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 27 gen 1997 Consegnato il 28 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal sum of £34,729 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 1 x new unilect assembly machine serial number: 9612/2006. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 ott 1990 Consegnato il 17 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land formerly known as dyers yard hilldrop lane ramsbury wiltshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Counter indemnity | Creato il 07 ott 1982 Consegnato il 26 ott 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 5,915,000 japanese yen standing in or to be credited to a designated account with lloyds bank PLC & all interest now due & henceforth to become due in respect thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 ago 1982 Consegnato il 31 ago 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery all stocks shares & other securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0