BATEMAN CHAPMAN LIMITED

BATEMAN CHAPMAN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBATEMAN CHAPMAN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01609862
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Standard House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATTHEWS BATEMAN LIMITED17 set 198217 set 1982
    SLYGOW LIMITED28 gen 198228 gen 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 27 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Charles Taylor Administration Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Robert Bird come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da International House 1 st Katharines Way London E1W 1UT in data 05 gen 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    13 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    legacy

    3 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    9 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BATEMAN CHAPMAN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Segretario
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3413040
    157558200001
    ELY, Thomas Damian
    9 Mayfield Avenue
    W4 1PN London
    Amministratore
    9 Mayfield Avenue
    W4 1PN London
    EnglandBritishInsurance Manager59348270003
    FITZSIMONS, George William
    30 Barrowfield
    Cuckfield
    RH17 5ER Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    30 Barrowfield
    Cuckfield
    RH17 5ER Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant105693390001
    BIRD, Robert Arthur
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    British23723280001
    DEAN, Margaret Ann
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    British3390760001
    CHAPMAN, Dudley
    Blossom Hill
    OX29 7QZ Yelford
    Oxon
    Amministratore
    Blossom Hill
    OX29 7QZ Yelford
    Oxon
    United KingdomBritishLoss Adjuster3390770001
    CLARK, Christopher Alan
    5 Auton Place
    RG9 1LG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Auton Place
    RG9 1LG Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishLoss Adjuster3390780003
    DE LA SALLE, Trevor William
    55 Welsummer Way
    EN8 0UG Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Welsummer Way
    EN8 0UG Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishInsurance Adjuster80683960001
    DEAN, Margaret Ann
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    BritishSecretary3390760001
    DYE, Christopher Howard
    30 West Grove
    KT12 5NX Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    30 West Grove
    KT12 5NX Walton On Thames
    Surrey
    BritishLoss Adjuster76449180001
    MASON, John
    Park Farm Oast
    Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Park Farm Oast
    Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    BritishLoss Adjuster69478170001
    MCMAHON, Joseph
    Willows
    Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Willows
    Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishLoss Adjuster186218380001
    OINN, Martin Philip
    36 Saxon Way
    CB11 4EG Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    36 Saxon Way
    CB11 4EG Saffron Walden
    Essex
    BritishLoss Adjuster80683660001
    SMILLIE, James Brown
    Tusker House
    Lea
    SN16 9PG Malmesbury
    Amministratore
    Tusker House
    Lea
    SN16 9PG Malmesbury
    BritishLoss Adjuster3390800003
    VINER, David William
    6 Appledown Rise
    CR5 2DX Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    6 Appledown Rise
    CR5 2DX Coulsdon
    Surrey
    BritishLoss Adjuster80683820001

    BATEMAN CHAPMAN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 dic 2005
    Consegnato il 16 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right,title and interest from time to time in and to each of the following assets the real property,the tangible moveable property,the account,the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 16 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 giu 2004
    Consegnato il 21 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 lug 1998
    Consegnato il 17 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 nov 1995
    Consegnato il 08 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings at wycombe air park clay lane marlow buckinghamshire t/n bm 181526 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 nov 1995
    Consegnato il 08 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 set 1986
    Consegnato il 12 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a factoring agreement.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Century Factors Limited
    Transazioni
    • 12 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 22 ago 1986
    Consegnato il 01 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0