REMAC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REMAC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01610100 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REMAC LIMITED?
- Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova REMAC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Fisher House PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Cumbria |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di REMAC LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per REMAC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jason Washington il 06 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Paul Henry il 14 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Henry John Marsh come segretario in data 03 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael John Hoggan come segretario in data 03 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Procter Vick come segretario in data 26 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael John Hoggan come segretario in data 26 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Harris come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REMAC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH, James Henry John | Segretario | Michaelson Road LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria United Kingdom | 235029350001 | |||||||
| HENRY, Nicholas Paul | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | United Kingdom | British | 102250610005 | |||||
| KILPATRICK, Stuart Charles | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | United Kingdom | British | 109536720001 | |||||
| READ, Paul Michael, Doctor | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 115464300001 | |||||
| WASHINGTON, Jason Nicholas | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 154486500004 | |||||
| HOGGAN, Michael John | Segretario | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | 207758430001 | |||||||
| KERR, Gordon William, Finance Director | Segretario | 47 Meadowburn Bishopbriggs G64 3HA Glasgow Lanarkshire | British | 120681150001 | ||||||
| READ, Derek | Segretario | Hillside Cottage Meadow Lane Off Redhill Road Storeton CH63 6HG Wirral Merseyside | British | 16142860001 | ||||||
| TYLER, Justin John Blakeney | Segretario | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | British | 116694740001 | ||||||
| VICK, Jonathan Procter | Segretario | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | British | 154038220001 | ||||||
| GALLAGHER, Craig Richard | Amministratore | 33 Boclair Road G61 2AF Bearsden Stronvar Lanarkshire | Scotland | British | 120508900002 | |||||
| HARRIS, Timothy Charles, Mr Cbe Fca Acma | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 178982590001 | |||||
| KERR, Gordon William, Finance Director | Amministratore | 47 Meadowburn Bishopbriggs G64 3HA Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 120681150001 | |||||
| LIDDICOTT, Stephen James | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 100867630001 | |||||
| MAY, Derek | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 10007480003 | |||||
| MCCORMAC, Anthony James | Amministratore | Eventide Cottage Mill Lane Greasby CH49 3NT Wirral Merseyside | England | British | 21952400001 | |||||
| MCCORMAC, Valerie | Amministratore | Eventide Cottage Mill Lane Greasby CH49 3NT Wirral Merseyside | British | 21952410001 | ||||||
| READ, Derek | Amministratore | Hillside Cottage Meadow Lane Off Redhill Road Storeton CH63 6HG Wirral Merseyside | British | 16142860001 | ||||||
| READ, Mary Elizabeth Ann | Amministratore | Hillside Cottage Meadow Lane Redhill Road Storeton CH63 6HG Wirral Merseysdie | British | 21952420001 | ||||||
| SHIELDS, Michael John | Amministratore | PO BOX 4 LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria | England | British | 12781030001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REMAC LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Fisher Nuclear Limited | 06 apr 2016 | Oldmeldrum AB51 0GQ Inverurie North Meadows Aberdeenshire Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
REMAC LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 26 apr 1996 Consegnato il 08 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a the wedding house, 24 pownall square, liverpool, merseyside t/no. MS235070 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 26 giu 1990 Consegnato il 02 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 29 dic 1983 Consegnato il 09 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 123 botanic rd, liverpool L6 merseyside.tn ms 164794 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 29 dic 1983 Consegnato il 09 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 16 corne st, liverpool L6 merseyside tn ms 113699 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 29 dic 1983 Consegnato il 09 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 13 holland st liverpool L6 merseyside tn ms 28252 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0