SEPROL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSEPROL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01610543
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SEPROL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SEPROL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old School School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SEPROL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CSE - SEPROL LIMITED10 set 200210 set 2002
    SEPROL LIMITED31 gen 198631 gen 1986
    SERVELEC SEPROL LIMITED01 feb 198201 feb 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di SEPROL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SEPROL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    8 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2021 al 30 giu 2022

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Robert Hugh Binns come amministratore in data 26 ago 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael James Audis come amministratore in data 26 ago 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Adam John Witherow Brown come amministratore in data 26 ago 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Crichton come amministratore in data 26 ago 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Leo Belfer come amministratore in data 26 ago 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Straddle Wharf Street Sheffield S2 5SY England a The Old School School Lane Stratford St. Mary Colchester CO7 6LZ in data 01 set 2021

    1 pagineAD01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 04 feb 2021

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Simon Leo Belfer come amministratore in data 11 dic 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Ian Crichton come amministratore in data 18 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Stubbs come amministratore in data 18 lug 2019

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SEPROL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AUDIS, Michael James
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    Amministratore
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    EnglandBritish248206260001
    BINNS, Robert Hugh
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    Amministratore
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    EnglandBritish206402020006
    BROWN, Adam John Witherow
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    Amministratore
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    EnglandBritish277451830001
    ATKINSON, Neil
    Rose Cottage
    Water End
    YO43 4HA Holme On Spalding Moor
    Yorkshire
    Segretario
    Rose Cottage
    Water End
    YO43 4HA Holme On Spalding Moor
    Yorkshire
    British39133100001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    CANE, Michael
    Wharf Street
    S2 5SY Sheffield
    The Straddle
    England
    Segretario
    Wharf Street
    S2 5SY Sheffield
    The Straddle
    England
    173406010001
    RILEY, Michael Alfred
    Rotherside Road
    Eckington
    S31 9HL Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Rotherside Road
    Eckington
    S31 9HL Sheffield
    South Yorkshire
    British37321170001
    SIMONDS, Geoffrey Charles
    7 Harding Close
    Rawmarsh
    S62 7HD Rotherham
    South Yorkshire
    Segretario
    7 Harding Close
    Rawmarsh
    S62 7HD Rotherham
    South Yorkshire
    British52372550001
    ATKINSON, Neil
    Rose Cottage
    Water End
    YO43 4HA Holme On Spalding Moor
    Yorkshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Water End
    YO43 4HA Holme On Spalding Moor
    Yorkshire
    British39133100001
    BELFER, Simon Leo
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    Amministratore
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    ScotlandBritish214271900001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CANE, Michael Geoffrey
    Wharf Street
    S2 5SY Sheffield
    The Straddle
    England
    Amministratore
    Wharf Street
    S2 5SY Sheffield
    The Straddle
    England
    EnglandBritish162222440001
    COPE, John Arthur
    Thornwick Lodge Station Road
    DE45 1GA Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Thornwick Lodge Station Road
    DE45 1GA Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritish8678230001
    COURT, Philip Adrian
    2 Sandstone Avenue
    Walton
    S42 7NS Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    2 Sandstone Avenue
    Walton
    S42 7NS Chesterfield
    Derbyshire
    British9207410001
    CRICHTON, Ian Francis
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    Amministratore
    School Lane
    Stratford St. Mary
    CO7 6LZ Colchester
    The Old School
    England
    ScotlandBritish260313630001
    CULLEN, Leslie Gray
    32 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish15782290001
    FIELD, Sally Ann
    20 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    Amministratore
    20 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    British541260001
    GILBY, Alan Stewart
    15 Lidget Close
    S26 4SX Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    15 Lidget Close
    S26 4SX Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish96906430001
    MILNER, Geoffrey Stephen
    Downtop
    Kings Drive
    ST18 0AJ Hopton
    Stafford
    Amministratore
    Downtop
    Kings Drive
    ST18 0AJ Hopton
    Stafford
    British9207420001
    STUBBS, Alan
    10 Sovereign Court
    Alwoodley
    LS17 7UT Leeds
    Amministratore
    10 Sovereign Court
    Alwoodley
    LS17 7UT Leeds
    EnglandBritish44856840006

    Chi sono le persone con controllo significativo di SEPROL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Rotherside Road
    Eckington
    S21 4HL Sheffield
    Servelec Group
    England
    06 apr 2016
    Rotherside Road
    Eckington
    S21 4HL Sheffield
    Servelec Group
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03098411
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SEPROL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2016
    Consegnato il 04 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2016
    Consegnato il 04 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2016
    Consegnato il 04 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 09 ott 1995
    Consegnato il 19 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 09 ott 1995
    Consegnato il 14 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (other than dividends on any shares) due or to become due from schemepark limited to the chargee under an investment agreement dated 9TH october 1995
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC as Security Trustee for Itself and the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 14 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 gen 1984
    Consegnato il 30 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0