CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01612613
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOLVERS LIMITED18 apr 198618 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 dic 2013

    Stato del capitale al 19 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2013

    11 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Nomina di Denise Williams come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mrs Barbara Ann Firth come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario

    2 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 apr 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012

    3 pagineCH01

    Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Kerry Jane Crompton il 16 mag 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952100001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Segretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    MCGRATH, John
    215 Britten Road
    Brighton Hill
    RG22 4HW Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    215 Britten Road
    Brighton Hill
    RG22 4HW Basingstoke
    Hampshire
    Irish86625860001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Segretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SPICER, Barry Leslie
    3 Inwood Kilns
    The Street Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    Segretario
    3 Inwood Kilns
    The Street Binsted
    GU34 4PB Alton
    Hampshire
    British41726530001
    STAFFORD, Andy
    Park House
    Park Terrace
    KT4 Worcester Park
    Surrey
    Segretario
    Park House
    Park Terrace
    KT4 Worcester Park
    Surrey
    British23777210001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    GOODBOURN, Caroline
    Honeysuckle Cottage
    London Road, Hill Brow
    GU33 7NS Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Honeysuckle Cottage
    London Road, Hill Brow
    GU33 7NS Liss
    Hampshire
    British51272690003
    GORDON, Christopher Murray
    Farthings Rake Road
    GU33 7HB Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Farthings Rake Road
    GU33 7HB Liss
    Hampshire
    British16761550001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    O'MALLEY, Douglas Charles
    Sunnycroft Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Sunnycroft Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AR Guildford
    Surrey
    British16761560001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    THOMPSON, Martin
    10 Oakley Dell
    GU4 7HJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    10 Oakley Dell
    GU4 7HJ Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish51272670002
    VELUSSI, Luca
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomItalian113413330002

    CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 19 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mar 2002
    Consegnato il 26 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ockford mill osckford road godalming surrey title number SY445686.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a ockford mill ockford road godalming surrey t/n SY393323 and SY445686. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit guarantee registered pursuant to an order or court dated 11/6/92
    Creato il 30 ago 1988
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee agreement
    Brevi particolari
    Rent deposit funds in the sum of £31,500 plus accrued interest thereon held by the mortgagees in a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Associated British Foods Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 17 giu 1988
    Consegnato il 07 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2014Inizio della liquidazione
    05 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0