01613643 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01613643 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01613643
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01613643 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova 01613643 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 8 South Fork Industrial Estate Dartmouth Way
    Garnet Road
    LS11 5JL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01613643 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2019
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ago 2020
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 ago 2018

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 01613643 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al23 dic 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma03 feb 2021
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al23 dic 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 01613643 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed victoria foods\certificate issued on 03/03/23
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 01 giu 2020

    • Capitale: GBP 0.999999
    7 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 27/05/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Matthew Lee come amministratore in data 31 mar 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David Leslie Cox come amministratore in data 04 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Power come amministratore in data 27 set 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 26 ago 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Henry Strother Colquhoun Breese come amministratore in data 24 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Clare Elizabeth Urmston come amministratore in data 26 set 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 27 ago 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Clare Elizabeth Urmston come amministratore in data 26 mag 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henrik Nygaard Pade come amministratore in data 25 feb 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Edward Kitson come segretario in data 24 feb 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Edward Kitson come amministratore in data 24 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Matthew Lee come amministratore in data 13 feb 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 28 ago 2016

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di 01613643 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    BREESE, Henry Strother Colquhoun
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Symington's Limited
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Symington's Limited
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant252692550001
    COX, David Leslie
    Thornes Farm Business Park
    LS9 0DN Leeds
    Symington's
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Thornes Farm Business Park
    LS9 0DN Leeds
    Symington's
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCheif Executive Officer196418130001
    BLACKLEDGE, John
    26 Iredale Crescent
    Standish
    WN6 0UD Wigan
    Lancs
    Segretario
    26 Iredale Crescent
    Standish
    WN6 0UD Wigan
    Lancs
    British56912400003
    KITSON, John Edward
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    Segretario
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    170179850001
    ROSS, Andrea Elizabeth
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    British37890560002
    BLACKLEDGE, John
    26 Iredale Crescent
    Standish
    WN6 0UD Wigan
    Lancs
    Amministratore
    26 Iredale Crescent
    Standish
    WN6 0UD Wigan
    Lancs
    EnglandBritishCommercial Director56912400003
    BOYLE, Nigel
    Callender Court
    Callender Street
    BL0 9DX Ramsbottom
    Flat 4
    Lancashire
    Amministratore
    Callender Court
    Callender Street
    BL0 9DX Ramsbottom
    Flat 4
    Lancashire
    BritishOperations Director136253710001
    BREWOOD, Keith Howard
    27 Reeveswood
    Eccleston
    PR7 5RS Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    27 Reeveswood
    Eccleston
    PR7 5RS Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishOperations Director58205000001
    FARMER, Paul Andrew
    Goose House
    Goose Lane
    WA4 5PA Hatton
    Warrington
    Amministratore
    Goose House
    Goose Lane
    WA4 5PA Hatton
    Warrington
    BritishOperations Director73760550001
    KITSON, John Edward
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector102500730001
    LEE, Matthew
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Commercial Officer276195940001
    LOFTUS, Kevin Patrick
    Apartment 8
    31 Whitworth Street West
    M1 5NG Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    Apartment 8
    31 Whitworth Street West
    M1 5NG Manchester
    Lancashire
    BritishSales & Marketing Director56912360002
    PADE, Henrik Nygaard
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant170156180001
    POWER, John
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Thornes Farm Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer216592640001
    ROSS, Andrea Elizabeth
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector37890560002
    ROSS, Daniel John Benedict
    Legh Croft
    Legh Road
    WA16 8LP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Legh Croft
    Legh Road
    WA16 8LP Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director37890570006
    ROSS, John
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Abbey House Macclesfield Road
    Chelford
    SK11 9AH Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishChairman37890580002
    SALKELD, David John
    Dartmouth Way
    Garnet Road
    LS11 5JL Leeds
    Unit 8 South Fork Industrial Estate
    England
    Amministratore
    Dartmouth Way
    Garnet Road
    LS11 5JL Leeds
    Unit 8 South Fork Industrial Estate
    England
    EnglandBritishDirector111995510001
    TANSEY, James
    56a Stocks Lane
    Penketh
    WA5 2RN Warrington
    Amministratore
    56a Stocks Lane
    Penketh
    WA5 2RN Warrington
    BritishProduction Director37983760001
    URMSTON, Clare Elizabeth
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Symington's Limited
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Pontefract Lane
    LS9 0DN Leeds
    Symington's Limited
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant233196110001
    WITHE, Paul
    10 Oakdale Drive
    L49 3PZ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    10 Oakdale Drive
    L49 3PZ Wirral
    Merseyside
    BritishProduction Director66312800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 01613643 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    South Fork Industrial Estate
    Dartmouth Way
    LS11 5JL Leeds
    Unit 8
    United Kingdom
    06 apr 2016
    South Fork Industrial Estate
    Dartmouth Way
    LS11 5JL Leeds
    Unit 8
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2528254
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per 01613643 LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    23 dic 201605 set 2016La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    01613643 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 lug 2016
    Consegnato il 09 ago 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Fixed charge over all the assets and undertaking of the company, present and future, as further described in clause 3 of the debenture. For more details please refer to instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2012
    Consegnato il 06 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security agent as trustee for the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee in all the company's right, title amd interest the tangible moveable property, the accounts, the material intellectual property, any goodwill see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal assignment
    Creato il 31 ago 2011
    Consegnato il 01 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 07 ott 2010
    Consegnato il 09 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 09 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 04 giu 2003
    Consegnato il 07 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property known as 2 parcels of land on the east side of bright street leigh t/n GM640370. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 20 set 2002
    Consegnato il 21 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 21 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 21 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as land and buildings on the east side of bright street leigh wigan greater manchester title number GM271258. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 set 2002
    Consegnato il 13 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 giu 1996
    Consegnato il 24 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & factory at bright street leigh lancs t/no's GM271258 GM640370.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on discounted debts
    Creato il 03 ott 1995
    Consegnato il 10 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 29 ott 1992
    Consegnato il 06 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures see 395 for property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 10 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the east side of bright street leigh wigan grt. Manchester title no. Gm 271258 and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 mag 1986
    Consegnato il 13 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 ago 1983
    Consegnato il 25 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 22/8/83
    Brevi particolari
    Fixed charge over land at bright street leigh greater manchester title no: gm 271258 floating charge over the undertaking & assets present & future inc. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Romix Foods Limited
    Transazioni
    • 25 ago 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0