SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01614052 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CORDIANT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 16 mar 1995 | 16 mar 1995 |
| SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 21 mag 1982 | 21 mag 1982 |
| BLANCHBERRY LIMITED | 15 feb 1982 | 15 feb 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 5 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Kenneth Billingsley come amministratore in data 02 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Annette King come amministratore in data 29 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Nicola Raj come segretario in data 07 giu 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ms Sophie Marie Cassandre Martin-Chantepie come amministratore in data 31 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Justin Kenneth Billingsley come amministratore in data 31 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Senior come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Senior come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alex Bekkerman come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Raj Basran come segretario in data 18 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Alan Harker come amministratore in data 03 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alex Bekkerman come amministratore in data 30 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Senior come amministratore in data 30 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Miss Joanne Munis come segretario in data 07 apr 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Anne Bailey come segretario in data 02 apr 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Segretario | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 196642710001 | |||||||
| RAJ, Nicola | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357370001 | |||||||
| CARRIGAN, James Joseph, Mr. | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 127439710001 | |||||
| KING, Annette | Amministratore | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | United Kingdom | British | 152540840001 | |||||
| MARTIN-CHANTEPIE, Sophie Marie Cassandre | Amministratore | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | France | French | 228671040001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Segretario | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 185511320001 | |||||||
| BASRAN, Raj | Segretario | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 170042570001 | |||||||
| BINDING, David Wyn | Segretario | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||
| DAVIS, Robert | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155474540001 | ||||||
| EARL, Elizabeth Louise Kiernan | Segretario | 9 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 105197540001 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Segretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| EWING, Susanna | Segretario | 72f Sinclair Road W14 0NJ London | British | 122102410001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina | Segretario | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | Finnish | 119965730001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Segretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore | Segretario | 6 Berkeley Road TN1 1YR Tunbridge Wells Kent | British | 54236170003 | ||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Segretario | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | 160075100001 | |||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Segretario | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WYLLIE, Alison | Segretario | Flat 2 186 Ladbroke Grove W10 5LZ London | British | 107811220001 | ||||||
| BEKKERMAN, Alex | Amministratore | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | American | 198886380001 | |||||
| BILLINGSLEY, Justin Kenneth | Amministratore | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | Australian | 228671340001 | |||||
| BINDING, David Wyn | Amministratore | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||
| BUNTON, Christopher John | Amministratore | 12 The Chowns AL5 2BN Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 1321820001 | |||||
| COURET, Philippe Francois Pierre | Amministratore | Flat 9 1 Prince Of Wales Terrace W8 5PG London | French | 68861790003 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Amministratore | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GRAHAM, Alec | Amministratore | Linden Lea, Packhorse Road Bessels Green TN13 2QP Sevenoaks Kent | British | 73621260001 | ||||||
| HARKER, Alan | Amministratore | Avonmore Road Kensington Village W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 174823410001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Amministratore | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| JANS, Annamaria | Amministratore | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| SAATCHI, Charles | Amministratore | 26 St Leonard's Terrace Chelsea SW3 4QG London | British | 11321230001 | ||||||
| SAATCHI, Maurice Nathan, The Lord | Amministratore | 44 Bruton Place Berkeley Square W1X 7AA London | United Kingdom | British | 33348130002 | |||||
| SENIOR, Robert William | Amministratore | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London | England | British | 178019870001 | |||||
| SMYTH, Wendy | Amministratore | Holly House Burtonhole Lane Mill Hill NW7 1AZ London | United Kingdom | British | 54779980001 | |||||
| WATSON, Robert Drummond | Amministratore | 2 Whybourne Crest TN2 5BS Tunbridge Wells Kent | British | 11918650001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Amministratore | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Amministratore | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SAATCHI & SAATCHI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 15 dic 1997 Consegnato il 24 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 apr 1993 Consegnato il 04 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and the standby facility agreement (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subject facilities pledge agreement bridge facility pledge agreement | Creato il 27 mar 1991 Consegnato il 12 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee, under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge. | |
Brevi particolari The company's interest in all securities and instrument collateral (see 395 and cont'd sheets for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subject facilities pledge agreement. New facility and standby facility pledge agreement | Creato il 27 mar 1991 Consegnato il 12 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge | |
Brevi particolari The company's interest in all securities and instrument collateral (see 395 and cont'd sheets for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subject facilities pledge agreement. | Creato il 27 mar 1991 Consegnato il 12 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee under the terms of each relevant facility (as defined) and the agreement and/or this charge | |
Brevi particolari The company's interest in all securities and instrument collateral (see form 395 & cont'd sheets for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0