BRITTON PRECISION LIMITED

BRITTON PRECISION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITTON PRECISION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01614754
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITTON PRECISION LIMITED?

    • fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profili in plastica (22210) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BRITTON PRECISION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITTON PRECISION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECISION PACKAGING LIMITED14 ott 198214 ott 1982
    PRECISION PACKAGING (ALFORD) LIMITED17 feb 198217 feb 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITTON PRECISION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITTON PRECISION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancelling capital redemption reserve 21/08/2012
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 22 ago 2012

    • Capitale: GBP 0.45
    4 pagineSH19

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael Clark come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Clark il 06 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BRITTON PRECISION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Segretario
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    British42598360003
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritish42598360003
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    Segretario
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    British28376970001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Segretario
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    British94622690001
    BRUTON, Paul Howard
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    British35532290001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Segretario
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    British78877930001
    KITCHING, Vanessa
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    British7064910001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Segretario
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Segretario
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    Amministratore
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    British28376970001
    BEAUMONT, Nigel Peter
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British95868800001
    BELL, Roger
    Swineshead Road
    Frampton Fen
    PE20 1SF Boston
    Willoughby Cottage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Swineshead Road
    Frampton Fen
    PE20 1SF Boston
    Willoughby Cottage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish136572770001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Amministratore
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritish94622690001
    BRUTON, Paul Howard
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    126 Berkeley Avenue
    HP5 2RT Chesham
    Buckinghamshire
    British35532290001
    BURNHAM, Jedidiah James
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    American56560680001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritish92294570002
    CONSTANCIO, Gail Ann
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    American55754050001
    COORS, Jeffrey
    16000 Table Mountain Parkway
    80403 Golden
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    16000 Table Mountain Parkway
    80403 Golden
    Colorado
    Usa
    American56564870001
    GORDON, Norman Stanley
    47 Eaton Square
    SW1W 9BD London
    Amministratore
    47 Eaton Square
    SW1W 9BD London
    British39113790001
    HOLLAMBY, Nicholas James
    Stone Barn House
    Croxton Kerrial
    NG32 1QP Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Stone Barn House
    Croxton Kerrial
    NG32 1QP Grantham
    Lincolnshire
    British59867600001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritish78877930001
    KITCHING, Michael
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    British7064920001
    KITCHING, Vanessa
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    West Park
    Barnoldby Le Beck
    DN37 0AS Grimsby
    North East Lincolnshire
    British7064910001
    MCCARTHY, John
    10 Farnham Close
    HP3 0QT Bovingdon
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Farnham Close
    HP3 0QT Bovingdon
    Hertfordshire
    British40441090001
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    Amministratore
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    British59839640001
    MOWER, Paul
    Holly House
    Keiths Wood
    SG3 6PU Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Holly House
    Keiths Wood
    SG3 6PU Knebworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish3316670001
    PARISH, Beth Anne
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    Usa55754140001
    PETERS, Raymond Albert
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish70111470001
    ROWE, Simon
    60 Turnberry
    Ouston
    DH2 1LR Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    60 Turnberry
    Ouston
    DH2 1LR Chester Le Street
    County Durham
    British43196500001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Amministratore
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritish73033280001
    SELINSKE, Steven
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    Amministratore
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    American57338010001
    SISSON, Jill Bartlett Woodman
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American56560720001
    SMITH, Colin Alfred
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    Amministratore
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    EnglandBritish66857520002
    STOREY, Roy
    The Manor House
    Stewton
    LN11 8SE Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Manor House
    Stewton
    LN11 8SE Louth
    Lincolnshire
    British7064930001

    BRITTON PRECISION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) land and buildings on the south east side of tattershall way, louth, lincolnshire t/no. LL66768 (ii) unit BT617/2 fairfield industrial estate, louth; and (iii) land off tattershall way, louth. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the holders of the ever 2284 limited variable rate loan notes 2013 (the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south west side of tattershall way louth t/n LL66768, unit BT617/2 fairfield industrial estate louth and land off tattershall way louth. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A guarantee and debenture made between the companies listed on the shedule attached to the form 395 (together the "charging companies"), the chargee and the cvc entities named therein
    Creato il 02 nov 2001
    Consegnato il 19 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each of the charging companies has covenanted and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the noteholders in accordance with the terms of the loan note instrument pay to the subordinated security agent for the account of each of the beneficiaries all moneys obligations and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred by it or by any other group company (including any other company) to each of the noteholders under the loan note instrument and whether on or after such demand whether actually or contingently whether solely or jointly with any other person whether as principal or surety and whether or not the relevant beneficiary was an original party to the relevant transaction including all interest commission fees charges costs and expenses which each beneficiary may in the course of its business charge or incur in respect of any company or its affairs and so that interest shall be computed and compounded in accordance with the loan note instrument (after as well as before any demand or judgment)
    Brevi particolari
    Properties as listed on the schedule attached to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Subordinated Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 19 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 apr 1998
    Consegnato il 06 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 06 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 31 dic 1990
    Consegnato il 11 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 ott 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Approx 0-13 acres of f/h land adjoining factory premises at tattershall way fairfield industrial estate, louth, lincs.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 08 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold factory premises situate at tattershall way, fairfield industrial estate louth lincs.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage and charge
    Creato il 07 lug 1988
    Consegnato il 07 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    70KN low base dolci extruder with screw l/d 30:1, our cooling to barrel by 4 fans (please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transazioni
    • 07 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 gen 1987
    Consegnato il 05 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage and charge
    Creato il 08 gen 1987
    Consegnato il 09 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Model 90KR low base dolci extruder (please see form 395 for full details & specifications).
    Persone aventi diritto
    • Charterd Trust Public Limitec Company
    Transazioni
    • 09 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage & charge
    Creato il 14 nov 1985
    Consegnato il 15 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Model 70KR low base dolci extruder (see doc M13 for details).
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1984
    Consegnato il 23 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Model 40KR dolci extruder (see doc M12) for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 nov 1982
    Consegnato il 05 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0