D J S CONTRACTS LIMITED

D J S CONTRACTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD J S CONTRACTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01618855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D J S CONTRACTS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova D J S CONTRACTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di D J S CONTRACTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per D J S CONTRACTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per D J S CONTRACTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* in data 24 set 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2013

    Stato del capitale al 25 giu 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Andrew Paul Gadsby come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Barnard come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Amy Williamson come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Amy Williamson come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Kirsty Daly come segretario

    1 pagineTM02

    Stato del capitale al 12 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    6 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 23/12/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di D J S CONTRACTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Segretario
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish49141230004
    GADSBY, Andrew Paul
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    EnglandBritish74834980002
    BROMLEY, Heidi Elizabeth
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    Segretario
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    British33605720002
    CAMERON, Lindsey Helen
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Segretario
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Other132335590001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Segretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DALY, Kirsty
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    160697220001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Segretario
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    RODRIGUES, Michael Anthony
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    Segretario
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    British29404660001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Segretario
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WILLIAMSON, Amy
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    166981780001
    WRAITH CARTER, Gillian
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    Segretario
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    British109333000001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritish137736080001
    BEESTON, Alistair John
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    British10670790001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Amministratore
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CUNDALL, David
    The Coppice
    Warren Lane
    BN8 4HX North Chailey
    East Sussex
    Amministratore
    The Coppice
    Warren Lane
    BN8 4HX North Chailey
    East Sussex
    British29404670001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Amministratore
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    British103077710001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    Amministratore
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritish122158360001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    POWELL, Martin Edward
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    Amministratore
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    United KingdomBritish59795080001
    RODRIGUES, Michael Anthony
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    Amministratore
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    EnglandBritish29404660001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Amministratore
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritish64898180001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Amministratore
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004

    D J S CONTRACTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 30 lug 1990
    Consegnato il 06 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Old texaco depot, water lane, exeter, devon. Title no. Dn 169070; and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 26 apr 1990
    Consegnato il 04 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever by virtue of the agreements and the loan agreements (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed charge over all leasing agreements, all monies payable under such agreements, the goods comprised in the agreements, the benefit of all guarantees, indemnities and insurances etc. in connection with or relating to the agreements. (For full details see doc M98C).
    Persone aventi diritto
    • Standard Finance Limited and Ctl LTD.
    • Chartered Trust PLC, Chartered Leasing Limited, Ct Vehicle Leasing Limited
    Transazioni
    • 04 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment & charge of sub letting agreements.
    Creato il 31 gen 1990
    Consegnato il 01 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal agreement
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company in sub-leases in respert of goods, the benefit of all guarantees intermnities negotiable instruments & securities in connection with the sub-leases.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 01 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 lug 1989
    Consegnato il 26 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed
    Creato il 12 mag 1989
    Consegnato il 26 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire/lease purchase or leasing agreements.
    Brevi particolari
    The benefit of all rights in, all monies due under all guarantees given all insurances effected pursuant to all hire or lease agreements.
    Persone aventi diritto
    • General Guarantee Corporation Limited
    Transazioni
    • 26 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 02 gen 1986
    Consegnato il 07 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title & interest of the company in sub leases now or hereafter made by the company in respect of goods comprised in hp/leasing contract hire agreements now or hereafter made between the garage and the company tog. With the benefit of all guarantees, indemnities negotiable instruments & securities taken by the company in connection with the sub leases (see M15).
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited.
    Transazioni
    • 07 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 nov 1983
    Consegnato il 01 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc 13). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 02 nov 1982
    Consegnato il 09 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future inc. Goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 05 ott 1982
    Consegnato il 12 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of existing sub-let agreements and of future sub-let agreements
    Brevi particolari
    Hire or leasing agreements now made or hereafter to be made by the company in respect of goods comprised in hire purchase or leisure agreements now or hereafter made between the company and either of the mortgages tog. With all monies from time to time becoming payable under each hire or leasing agreements (see doc M11).
    Persone aventi diritto
    • Bowmaker (Commercial) Limited and Bowmaker Leasing Limited
    Transazioni
    • 12 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0