KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED

KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01623079
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    • (1533) /

    Dove si trova KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BAKKAVOR
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARKTONE LIMITED18 mar 198218 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    10 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 gen 2011

    Stato del capitale al 24 gen 2011

    • Capitale: GBP 15,209,415
    SH01

    Cessazione della carica di Richard Howes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sunita Kaushal come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2010

    11 pagineAA

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Miss Sunita Kaushal come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Jowett come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 27 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 29 dic 2007

    23 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 dic 2006

    30 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUDMUNDSSON, Agust
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    Amministratore
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    United KingdomIcelandicCompany Director79348500004
    COLLYER, Stephen Derek, Mr.
    11 Salisbury Road
    TW9 2JB Richmond
    Surrey
    Segretario
    11 Salisbury Road
    TW9 2JB Richmond
    Surrey
    BritishAccountant89995290001
    CONSTANTINOU, Loizos
    12 Bolton Crescent
    SL4 3JQ Windsor
    Berkshire
    Segretario
    12 Bolton Crescent
    SL4 3JQ Windsor
    Berkshire
    British28612240002
    DURRANT, Dawn Elizabeth
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    Segretario
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    BritishCompany Secretary47940000002
    JOWETT, Jonathan David
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Segretario
    43 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    BritishSolicitor103825760001
    KATSOURIS, Panicos
    6 Chatsworth Road
    W5 3DB London
    Segretario
    6 Chatsworth Road
    W5 3DB London
    British1902240002
    KAUSHAL, Sunita
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    Segretario
    West Marsh Road
    PE11 2BB Spalding
    Lincolnshire
    150206490001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Segretario
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    BritishFinancial Controller151217690001
    COLLYER, Stephen Derek, Mr.
    11 Salisbury Road
    TW9 2JB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    11 Salisbury Road
    TW9 2JB Richmond
    Surrey
    EnglandBritishAccountant89995290001
    CONSTANTINOU, Costas
    86 Merryhills Drive
    EN2 7PD Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    86 Merryhills Drive
    EN2 7PD Enfield
    Middlesex
    United KingdomCypriotDirector33262880003
    CONSTANTINOU, Loizos
    12 Bolton Crescent
    SL4 3JQ Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    12 Bolton Crescent
    SL4 3JQ Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector28612240002
    DURRANT, Dawn Elizabeth
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    112 Empingham Road
    PE9 2SU Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Secretary47940000002
    GUDMUNDSSON, Agust
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    Amministratore
    15 Upper Belgrave Street
    SW1X 8AB London
    United KingdomIcelandicDirector79348500004
    GUDMUNDSSON, Lydur
    68 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    Amministratore
    68 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    EnglandIcelandicDirector113042340001
    HARRIS, Jocelin Montague St John
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    Amministratore
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    United KingdomBritishDirector3078360002
    HOWES, Richard David
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Court
    20 Uppingham Road
    LE15 6JD Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director118715250001
    KATSOURIS, Panicos
    6 Chatsworth Road
    W5 3DB London
    Amministratore
    6 Chatsworth Road
    W5 3DB London
    BritishDirector1902240002
    PISHIRIS, Christopher
    56 The Ridings
    W5 3DR London
    Amministratore
    56 The Ridings
    W5 3DR London
    EnglandBritishRestauranteur4104910001
    PULLEN, Jonathan Mark
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishGroup Finance Director38923660001
    PUNNETT, Jolyon
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    Amministratore
    37 The Gowans Sutton On The Forest
    YO61 1DL Sutton On The Forest
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller151217690001
    VOYLE, Gareth John
    6 Northfield Court
    Conduit Street
    PE9 1RA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    6 Northfield Court
    Conduit Street
    PE9 1RA Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Secretary69027440005
    YEROLEMOU, Antonios Prodromou
    36 Beaufort Road
    W5 3EA London
    Amministratore
    36 Beaufort Road
    W5 3EA London
    EnglandBritishDirector4104900002

    KATSOURIS (FRESH FOODS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 24 mag 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at 304 elveden place park royal london NW10. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mag 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Agent
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 lug 1998
    Consegnato il 04 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 apr 1998
    Consegnato il 21 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at 304 elveden place willesden l/b of brent t/no;-ngl 707068 and the land adjoining with possessory t/o;-NGL707069.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Cyprus (London) Limited
    Transazioni
    • 21 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 feb 1986
    Consegnato il 03 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Durrington Corporation Limited
    Transazioni
    • 03 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 nov 1982
    Consegnato il 09 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Aspecific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including good will, bookdebts & the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 24 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0